ACCORD NETWORK MANAGEMENT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ACCORD NETWORK MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03497171 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ACCORD NETWORK MANAGEMENT LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova ACCORD NETWORK MANAGEMENT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ACCORD NETWORK MANAGEMENT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ACCORD JARVIS LIMITED | 10 apr 2000 | 10 apr 2000 |
| PRISMO DOYLE LIMITED | 17 apr 1998 | 17 apr 1998 |
| CABLEINFO LIMITED | 22 gen 1998 | 22 gen 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ACCORD NETWORK MANAGEMENT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per ACCORD NETWORK MANAGEMENT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Latham Nelson il 25 nov 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 15 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 14 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Birch il 16 gen 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Cessazione della carica di Andrew Lee Milner come amministratore in data 12 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 11 pagine | AA | ||
Dettagli del segretario cambiati per Sherard Secretariat Services Limited il 02 set 2019 | 1 pagine | CH04 | ||
Modifica dei dettagli di Accord Asset Management Limited come persona con controllo significativo il 02 set 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ a Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB in data 02 set 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 10 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Accord Asset Management Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 10 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Paul Birch come amministratore in data 12 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 10 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di ACCORD NETWORK MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom |
| 109588620001 | ||||||||||
| BIRCH, Paul | Amministratore | 142 Speke Road L19 2PH Liverpool The Matchworks England England | United Kingdom | British | 76116640004 | |||||||||
| NELSON, Andrew Latham | Amministratore | Chancery Exchange 10 Furnival Street EC4A 1AB London Amey United Kingdom | England | British | 36191090004 | |||||||||
| BAKER, Sally Vivienne | Segretario | 21 Merry Hurst Place Waterside Park LE10 0FG Hinckley Leicestershire | British | 84316160002 | ||||||||||
| BATEMAN, Andrew | Segretario | 34 Heath Close RG41 2PG Wokingham Berkshire | British | 24432680002 | ||||||||||
| BIRCH, Paul | Segretario | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | British | 76116640002 | ||||||||||
| FARRAR, Roland Martin | Segretario | 40 Chiltern Road SL6 1XA Maidenhead Berkshire | British | 29009510002 | ||||||||||
| KELLY, Paula Frona | Segretario | 12 Chells Lane SG2 7AA Stevenage Herts | British | 95469920001 | ||||||||||
| MORRIS, Amanda | Segretario | Dickens Close Galley Common CV10 9SQ Nuneaton 19 Warwickshire United Kingdom | British | 130333150001 | ||||||||||
| RAZWI, Sayad Hassan Raza | Segretario | 25 Church Road UB3 2LB Hayes Middlesex | British | 74192260001 | ||||||||||
| WELLS, Stephen | Segretario | 14 Tall Elms Close BR2 0TT Bromley Kent | British | 33998100001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ARNOLD, David Llewelyn | Amministratore | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 181213200001 | |||||||||
| ATHERTON, David | Amministratore | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House England | England | British | 109058740001 | |||||||||
| ATHERTON, David | Amministratore | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | England | British | 109058740001 | |||||||||
| ATKINS, Amanda | Amministratore | 69 Bellhouse Way Acomb Wood YO24 3LL York North Yorkshire | British | 117197920001 | ||||||||||
| ATKINSON, Phillip Antony | Amministratore | 46 Grove Road PO19 2AP Chichester West Sussex | British | 98986650001 | ||||||||||
| BOULTER, Marc Christian | Amministratore | New Cottage Kings Lane, Cookham SL6 9AY Maidenhead Berkshire | British | 77585810001 | ||||||||||
| CANNON, Peter John | Amministratore | 163 Oxford Road OX14 2AD Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | British | 43894690001 | |||||||||
| CHEETHAM, James Richard | Amministratore | Ashfield Weston Rhyn SY10 7SD Oswestry Salop | British | 45753210001 | ||||||||||
| CONNOR, Christopher John | Amministratore | 10 Elmscott Gardens N21 2BP Winchmore Hill London | United Kingdom | British | 141449690001 | |||||||||
| EVANS, David Clark | Amministratore | Lyle House 67 Marsham Way SL9 8AW Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 102876290001 | |||||||||
| EVANS, John | Amministratore | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | England | British | 124834920004 | |||||||||
| EWELL, Melvyn | Amministratore | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 61515760002 | |||||||||
| FALLS, Daniel Brian | Amministratore | 10 Salcombe Close NG16 2DQ Newthorpe Nottinghamshire | England | British | 180122750001 | |||||||||
| FELLOWES PRYNNE, Philip Windover | Amministratore | 76 The Shearers St Michaels Mead CM23 4AZ Bishops Stortford Hertfordshire | British | 80861440001 | ||||||||||
| FELLOWS PRYNNE, Philip Windover | Amministratore | 76 The Shearers St Michaels Mead CM23 4AZ Bishops Stortford Hertfordshire | British | 99777140001 | ||||||||||
| FLOATE, Ernst | Amministratore | 17 Ludlow Road Ealing W5 1NX London | British | 31983560001 | ||||||||||
| FOLBIGG, David Stanley | Amministratore | The Old School House Felmersham MK43 7HN Bedford Bedfordshire | British | 14310300001 | ||||||||||
| FRASER, Ian Ellis | Amministratore | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | Scotland | Uk | 28393850006 | |||||||||
| GOLDBERG, Michael | Amministratore | 33 Northcote Road DA14 6PN Sidcup Kent | British | 110304060001 | ||||||||||
| GRATTON, Gordon Cameron Paul | Amministratore | 1 Beckside Gardens LS16 5QZ Leeds West Yorkshire | England | British | 121813940001 | |||||||||
| GREGG, Nicholas Mark | Amministratore | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | England | British | 144667000001 | |||||||||
| HALL, Stephen John | Amministratore | 138 Western Way Darras Hall Ponteland NE20 9LY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 100985370001 | ||||||||||
| HARLAND, Ken Roy | Amministratore | 88 Cantley Lane DN4 6NH Bessacarr Doncaster | United Kingdom | British | 164491120001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ACCORD NETWORK MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accord Asset Management Limited | 06 apr 2016 | 10 Furnival Street EC4A 1AB London Chancery Exchange United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0