JENSTONE PROPERTIES LIMITED

JENSTONE PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJENSTONE PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03503117
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JENSTONE PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova JENSTONE PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    249 Cranbrook Road
    Ilford
    IG1 4TG Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JENSTONE PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JENSTONE LIMITED03 feb 199803 feb 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di JENSTONE PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per JENSTONE PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2022

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2021

    9 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2022 al 31 dic 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021

    9 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2019

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio modificato di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    11 pagineAAMD

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2018

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 gen 2016

    Stato del capitale al 19 gen 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    6 pagineAA

    Bilancio modificato per una piccola impresa redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAAMD

    Bilancio annuale redatto al 08 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 gen 2015

    Stato del capitale al 14 gen 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Chi sono gli amministratori di JENSTONE PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIS, Emma Sarah
    249 Cranbrook Road
    Ilford
    IG1 4TG Essex
    Segretario
    249 Cranbrook Road
    Ilford
    IG1 4TG Essex
    British148013900001
    DAVIS, Emma Sarah
    249 Cranbrook Road
    Ilford
    IG1 4TG Essex
    Amministratore
    249 Cranbrook Road
    Ilford
    IG1 4TG Essex
    United KingdomBritish148013900001
    DAVIS, Lewis John
    249 Cranbrook Road
    Ilford
    IG1 4TG Essex
    Amministratore
    249 Cranbrook Road
    Ilford
    IG1 4TG Essex
    EnglandBritish146476190001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Chi sono le persone con controllo significativo di JENSTONE PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lewis John Davis
    249 Cranbrook Road
    Ilford
    IG1 4TG Essex
    05 gen 2017
    249 Cranbrook Road
    Ilford
    IG1 4TG Essex
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.

    JENSTONE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over members' interests
    Creato il 25 mar 2013
    Consegnato il 30 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the cip (barrett st) LLP to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all of the chargor's right title benefit and interest from time to time in its member's interest together with all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital a Finance PLC
    Transazioni
    • 30 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 mar 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 13 lug 2001
    Consegnato il 20 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 29 to 31 high street epsom t/n SY155018 and SY280929. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 gen 2001
    Consegnato il 22 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 11 to 17 bank street rugby t/n WK125353. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 01 dic 2000
    Consegnato il 14 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 3 to 7 (odd) high street bedford t/no.BD200012. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 30 giu 1999
    Consegnato il 13 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 360/362 st johns street london EC2. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 30 giu 1999
    Consegnato il 13 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 set 1998
    Consegnato il 15 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from central investment properties limited ("the borrower") to the chargee in any manner whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a church house horsefair and 2 and 3 north bar banbury oxfordshire and the proceeds of sale thereof by way of floating charge all property and assets of whatsoever nature now or in the future owned or acquired by the company a specific equitable charge over all shares or membership rights or other rights an assignment of all the benefit of every insurance policy in respect of the property and assignment of the benefit of all guarantees warranties and reprsentations for full details of charged assets please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 15 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 lug 1998
    Consegnato il 08 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 lug 1998
    Consegnato il 08 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from central investment properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The church house horsefair and 2 and 3 north bar banbury oxfordshire and the proceeds of sale thereof and all compensation or grants payable. Floating charge over all property and assets of whatsoever nature. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transazioni
    • 08 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0