TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED

TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03503231
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    140 London Wall
    EC2Y 5DN London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PPM (PRIME) TRADING LIMITED28 gen 199828 gen 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 26 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 feb 2015

    Stato del capitale al 19 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Ernitia Ferguson come segretario in data 01 gen 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Aaron Jon Burns come segretario in data 01 gen 2015

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    3 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    5 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 28 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 gen 2014

    Stato del capitale al 28 gen 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    21 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Bastion House 140 London Wall London EC2Y 5DN* in data 23 ott 2012

    1 pagineAD01

    Nomina di Ernitia Ferguson come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di William Frost come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    23 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 04 apr 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 28 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 28 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    28 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Warren Persky il 18 ott 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURNS, Aaron Jon
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    Segretario
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    193862900001
    PERSKY, Warren Ashley
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    United Kingdom
    Amministratore
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    United Kingdom
    United KingdomBritish108635640073
    TRILLIUM GROUP LIMITED
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    Amministratore
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    103653140001
    TRILLIUM HOLDINGS LIMITED
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    Amministratore
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    103653930002
    BARLOW, Tracey Anne Kingsley
    25 Holmesdale Avenue
    SW14 7BQ London
    Segretario
    25 Holmesdale Avenue
    SW14 7BQ London
    British65520910002
    BINGLEY, Joan Hilary
    Eaton Farm
    Miles Lane
    KT11 2ED Cobham
    Surrey
    Segretario
    Eaton Farm
    Miles Lane
    KT11 2ED Cobham
    Surrey
    Irish1388610001
    DUDGEON, Peter Maxwell
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    Segretario
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    British14674480002
    FERGUSON, Ernitia
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    United Kingdom
    Segretario
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    United Kingdom
    168435690001
    FROST, William
    Bastion House 140 London Wall
    London
    EC2Y 5DN
    Segretario
    Bastion House 140 London Wall
    London
    EC2Y 5DN
    British134060040001
    WILSON, Gavin Edward Reid
    38 Upper Cheyne Row
    SW3 5JJ London
    Segretario
    38 Upper Cheyne Row
    SW3 5JJ London
    British56166890001
    BLAXLAND, Simon Thomas
    237 Rue Du Foubourg Saint Honore
    75008 Paris
    FOREIGN France
    Amministratore
    237 Rue Du Foubourg Saint Honore
    75008 Paris
    FOREIGN France
    British58254750001
    CHANDE, Manish Jayantilal
    9 Chester Place
    Regents Park
    NW1 4NB London
    Amministratore
    9 Chester Place
    Regents Park
    NW1 4NB London
    British83291490001
    ELLIS, Ian David
    Oak Lodge, Moor Road
    Great Tey
    CO6 1JJ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Oak Lodge, Moor Road
    Great Tey
    CO6 1JJ Colchester
    Essex
    EnglandBritish68191870001
    FRANCO, Jon Jacob
    Flat 10
    31 Collingham Road
    SW5 0NU London
    Amministratore
    Flat 10
    31 Collingham Road
    SW5 0NU London
    American64630220002
    FRIEDLOS, Nicholas Robert
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    Amministratore
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    EnglandBritish61183260002
    FROST, William
    Kenley Road
    SW19 3DU London
    77
    Amministratore
    Kenley Road
    SW19 3DU London
    77
    British134060040001
    GARMAN, James Robert
    Flat 5
    56 Lexham Gardens
    W8 5JA London
    Amministratore
    Flat 5
    56 Lexham Gardens
    W8 5JA London
    British68523620003
    GEORGI, Richard Evans
    Church Gate Hall Church Gate
    SW6 3LD London
    Amministratore
    Church Gate Hall Church Gate
    SW6 3LD London
    British56166880001
    GODDEN, David Roy
    20 Frensham Road
    GU9 8HE Farnham
    Surrey
    Amministratore
    20 Frensham Road
    GU9 8HE Farnham
    Surrey
    EnglandBritish1950780001
    GRIFFITHS OF FFORESTFACH, Brian, Lord
    19 Chester Square
    SW1W 9HS London
    Amministratore
    19 Chester Square
    SW1W 9HS London
    British42617760001
    HOLT, David Leslie Frank
    44 Osier Crescent
    Muswell Hill
    N10 1QW London
    Amministratore
    44 Osier Crescent
    Muswell Hill
    N10 1QW London
    British100070620001
    LOZIER JR, James
    3512 Crescent Avenue
    75205 Dallas
    Texas
    Usa
    Amministratore
    3512 Crescent Avenue
    75205 Dallas
    Texas
    Usa
    American59540870001
    MILLMAN, Milton
    1104 Hidden Ridge Drive 2005
    Irving Texas 75038
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    1104 Hidden Ridge Drive 2005
    Irving Texas 75038
    FOREIGN Usa
    American59779630001
    MURAIDEKH, Eli Sean
    Flat 2 136 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    Amministratore
    Flat 2 136 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    United KingdomBritish56166870001
    MYERS, Martin Trevor
    Durham Place
    SW3 4ET London
    1
    Amministratore
    Durham Place
    SW3 4ET London
    1
    EnglandBritish35819830001
    SISKIND, Edward
    61 Ledbury Road
    W11 2AA London
    Amministratore
    61 Ledbury Road
    W11 2AA London
    American64411260001
    SWEENEY, Peter Charles
    The Warren 61 Leas Road
    CR6 9LP Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    The Warren 61 Leas Road
    CR6 9LP Warlingham
    Surrey
    British30672780001
    WILSON, Gavin Edward Reid
    38 Upper Cheyne Row
    SW3 5JJ London
    Amministratore
    38 Upper Cheyne Row
    SW3 5JJ London
    British56166890001

    TRILLIUM (PRIME) TRADING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 19 nov 2009
    Consegnato il 26 nov 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag London Branch
    Transazioni
    • 26 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 08 lug 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 29 dic 2006
    Consegnato il 29 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the security under the charge is created in favour of the security trustee, is created over present and future assets and is security for the payment of all the secured liabilities.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 06 mag 2004
    Consegnato il 19 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, contracts, intellectual property, goodwill and uncalled capital floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 19 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 8TH april 1998
    Creato il 01 apr 1998
    Consegnato il 27 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chase manhattan bank (for itself and as trustee for each beneficiary) under each finance document, the existing swap and any hedging agreement (as defined in a security document dated 1ST april 1998)
    Brevi particolari
    All and whole that piece of ground extending to 468 square yards or thereby situated on the north east side of bank street in the burgh and county of inverness. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank
    Transazioni
    • 27 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 8TH april 1998
    Creato il 01 apr 1998
    Consegnato il 27 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chase manhattan bank (for itself and as trustee for each beneficiary) under each finance document, the existing swap and any hedging agreement (as defined in a security document dated 1ST april 1998)
    Brevi particolari
    All and whole that plot or area of ground at crosshill road bishopbriggs in the former parish of cawder and county of lanark which subjects form part and portion of that area of ground extending to 83.489 acres or thereby part of the lands and estate of cawder in the said former parish and county. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank
    Transazioni
    • 27 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 8TH april 1998
    Creato il 01 apr 1998
    Consegnato il 27 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chase manhattan bank (for itself and as trustee for each beneficiary) under each finance document, the existing swap and any hedging agreement (as defined in a security document dated 1ST april 1998)
    Brevi particolari
    All and whole that area of ground at hattonrigg road bellshill extending to 0.65 acres or thereby imperial standard measure lying in the parish of bothwell and county of lanark. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank
    Transazioni
    • 27 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security document
    Creato il 01 apr 1998
    Consegnato il 14 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee under each finance document, the existing swap and any hedging agreement to which such beneficiary is a party together with all costs, charges and expenses incurred by any beneficiary in connection with the protection, preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents except for any obligation which, if it were so included, would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985 (together the "secured liabilities")
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bankfor Itself and as Trustee for Each Beneficiary (As Defined Therein) (the "Security Trustee")
    Transazioni
    • 14 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0