WCPC REALISATIONS LIMITED
Panoramica
Nome della società | WCPC REALISATIONS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03504068 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WCPC REALISATIONS LIMITED?
- Altro commercio al dettaglio di alimentari in negozi specializzati (47290) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova WCPC REALISATIONS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Central Square 8th Floor 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WCPC REALISATIONS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
WEST CORNWALL PASTY CO LTD. | 03 mar 1998 | 03 mar 1998 |
REACHCHANGE COMPANY LIMITED | 04 feb 1998 | 04 feb 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WCPC REALISATIONS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 01 mar 2013 |
Quali sono le ultime deposizioni per WCPC REALISATIONS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 feb 2017 | 21 pagine | 4.68 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 16 pagine | 4.72 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP a Central Square 8th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 03 nov 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 apr 2016 | 19 pagine | 4.68 | ||||||||||
Domanda di insolvenza INSOLVENCY:secretary of states certificate of release of liquidator | 1 pagine | LIQ MISC | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario | 1 pagine | 4.40 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 16 apr 2015 | 19 pagine | 2.24B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 apr 2015 | 19 pagine | 2.24B | ||||||||||
Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori | 1 pagine | 2.34B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 ott 2014 | 16 pagine | 2.24B | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed west cornwall pasty co LTD.\certificate issued on 18/09/14 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 1 pagine | F2.18 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B | 18 pagine | 2.16B | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 44 pagine | 2.17B | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Dreason Lanhydrock Bodmin Cornwall PL30 4BG* in data 25 apr 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Rose come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 1 pagine | 2.12B | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 01 mar 2013 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Shelagh Smale come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Shelagh Mairi Joan Smale il 16 ott 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WCPC REALISATIONS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALE, Leigh Robert | Amministratore | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square 8th Floor | England | British | Finance Director | 177174220001 | ||||
GIPSON, Stephen | Amministratore | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square 8th Floor | Great Britain | British | Director | 98785200001 | ||||
MAIN, Matthew Stewart | Amministratore | 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square 8th Floor | United Kingdom | British | Company Director | 176990760001 | ||||
ALSTON, Tracey Crawford | Segretario | Lanhydrock PL30 4BG Bodmin Dreason Cornwall United Kingdom | 164924020001 | |||||||
CHRISTOPHERS, Mark Ian | Segretario | 15 Sudbury Gardens CR0 5JS Croydon Surrey | British | Private Equity Manager | 57149000001 | |||||
COLLINS, Sarah Frances | Segretario | 80 Wroughton Road SW11 6BG London | British | Solicitor | 54460690001 | |||||
HALL, Andrew James | Segretario | Lanhydrock PL30 4BG Bodmin Dreason Cornwall United Kingdom | 172910810001 | |||||||
MAGRATH, Patrick Edward | Segretario | Torr Farm Yealmpton PL8 2HR Plymouth Devon | British | None | 116644280001 | |||||
MOSELEY, Ian | Segretario | 7 West View Porthleven TR13 9LN Helston Cornwall | British | 71905000001 | ||||||
RIVERS, Paul Edward | Segretario | Fox Cottage Tubney OX13 5QL Abingdon 1a Oxon | British | Director | 62321110002 | |||||
RIVERS, Paul Edward | Segretario | Tubney OX13 5QL Abingdon Fox Cottage Oxon | 148823360001 | |||||||
SALISBURY, Adam James | Segretario | Lanhydrock PL30 4BG Bodmin Dreason Cornwall United Kingdom | 153086030001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
TARLO LYONS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Watchmaker Court 33 St Johns Lane EC1M 4DB London | 106974360001 | |||||||
ALSTON, Tracey Crawford | Amministratore | Lanhydrock PL30 4BG Bodmin Dreason Cornwall United Kingdom | England | British | Director | 163288410002 | ||||
BARBER, Sarah Alice | Amministratore | Pine Villa Trencrom Lane Carbis Bay TR26 2TA St. Ives Cornwall | British | Director | 57891580003 | |||||
BARBER, Victoria Louise | Amministratore | Pine Villa Trencrom Lane Carbis Bay TR26 2TA St. Ives Cornwall | Uk | British | Director | 60017010003 | ||||
BARRY, Michael James | Amministratore | Lemon Street TR1 2PN Truro 68 Cornwall | United Kingdom | British | Company Director | 96184620001 | ||||
CHRISTOPHERS, Mark Ian | Amministratore | Flat 5 10 Pembridge Crescent Notting Hill W11 3DT London | Great Britain | British | Director | 76124040005 | ||||
CHRISTOPHERS, Mark Ian | Amministratore | 15 Sudbury Gardens CR0 5JS Croydon Surrey | British | Private Equity Manager | 57149000001 | |||||
COCKING, Arron Mark | Amministratore | Penthouse 10 Porchester Terrace Bayswater W2 3TL London | British | Director | 76123990006 | |||||
COCKING, Arron Mark | Amministratore | 118 Blenheim Gardens RG1 5QJ Reading Berkshire | British | Shop Proprietor | 76123990001 | |||||
COCKING, Gavin Paul | Amministratore | Schoterweg 9a 2021 Hz Haarlem Netherlands | British | Director | 76124090006 | |||||
COCKING, Gavin Paul | Amministratore | 118 Blenheim Gardens RG1 5QJ Reading Berkshire | British | Shop Proprietor | 76124090001 | |||||
COCKING, Kenneth | Amministratore | Quethiock House Ganges Close Mylor Harbour TR11 5UG Falmouth Cornwall | England | British | Director | 76418690003 | ||||
EVANS, Treve Nicholas | Amministratore | 1 Belmont Road TR13 8UA Helston Cornwall | England | British | Director | 35265700001 | ||||
HALL, Andrew James | Amministratore | Lanhydrock PL30 4BG Bodmin Dreason Cornwall United Kingdom | England | British | Accountant | 30306840002 | ||||
MAGRATH, Patrick Edward | Amministratore | Torr Farm Yealmpton PL8 2HR Plymouth Devon | United Kingdom | British | None | 116644280001 | ||||
NIETO, Richard Keith | Amministratore | Deva Heights Dee Banks, Great Boughton CH3 5UA Chester 10 Cheshire | United Kingdom | British | None | 154059120001 | ||||
RIVERS, Paul Edward | Amministratore | Fox Cottage Tubney OX13 5QL Abingdon 1a Oxon | England | British | Director | 62321110002 | ||||
ROSE, Stuart Anthony | Amministratore | Lanhydrock PL30 4BG Bodmin Dreason Cornwall United Kingdom | England | British | Director | 87188070001 | ||||
SMALE, Shelagh Mairi Joan | Amministratore | Lanhydrock PL30 4BG Bodmin Dreason Cornwall United Kingdom | England | British | Marketing Director | 176990910001 | ||||
TETLEY, Victoria Shane | Amministratore | Lanhydrock PL30 4BG Bodmin Dreason Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 163721120001 | ||||
WILLIAMS, Gavin Laurence | Amministratore | Lanhydrock PL30 4BG Bodmin Dreason Cornwall United Kingdom | England | British | Director | 110995560001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
WCPC REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creato il 29 giu 2012 Consegnato il 06 lug 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The account and its balance from time to time. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
All monies debenture | Creato il 09 ott 2007 Consegnato il 16 ott 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 24 giu 2004 Consegnato il 26 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Holbrook house, old hill, helston, cornwall, t/no CL78052. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 giu 2004 Consegnato il 23 giu 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 08 lug 2002 Consegnato il 10 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a holbrook house old hill st johns helston cornwall. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 nov 2000 Consegnato il 05 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rental deposit deed | Creato il 10 feb 2000 Consegnato il 21 feb 2000 | In corso | Importo garantito All rent and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date | |
Brevi particolari Fixed charge all the company's interest in the interest earning deposit account to be opened by the landlord at hsbc bank PLC in the name of the landlord with the deposit being: £18,500. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 ago 1999 Consegnato il 21 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies from time to time and interest earned on the deposit account held at midland bank PLC, 103 streatham hill, london SW2 (the initial deposit being £4,750) as security for money payable from the company to the chargee (as defined in the rent deposit deed) | |
Brevi particolari All monies held from time to time (together with any interest) in the deposit account as defined in the rent deposit deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 20 giu 1999 Consegnato il 05 lug 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
WCPC REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In amministrazione |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0