GLANCEPRESS LIMITED

GLANCEPRESS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGLANCEPRESS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03507621
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GLANCEPRESS LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova GLANCEPRESS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GLANCEPRESS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2009

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GLANCEPRESS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per GLANCEPRESS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    11 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ago 2015

    13 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ago 2014

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ago 2013

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ago 2012

    11 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 ago 2011

    10 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * Kilnbrook House Rose Kiln Lane Reading Berkshire RG2 0BY United Kingdom* in data 13 ago 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di Mr Alistair Guy Smee come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 giu 2009

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Robert Silvester come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Silvester come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 10 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 feb 2010

    Stato del capitale al 24 feb 2010

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2008

    12 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di GLANCEPRESS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, William Quentin
    15 Crowsley Road
    Lower Shiplake
    RG9 3JU Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    15 Crowsley Road
    Lower Shiplake
    RG9 3JU Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishSurveyor28918420001
    SMEE, Alistair Guy
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Amministratore
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishChartered Surveyor126179690002
    SMEE, Roger Guy, Mr.
    Crazies Hall
    Crazies Hill
    RG10 8LY Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    Crazies Hall
    Crazies Hill
    RG10 8LY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomUnited KingdomDirector29088830008
    GREENWOOD, Patrick John Aberneithy
    24 Chestnut Avenue
    RG41 3HX Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    24 Chestnut Avenue
    RG41 3HX Wokingham
    Berkshire
    BritishChartered Accountant77514730001
    SILVESTER, Robert Peter, Mr.
    113 Seal Hollow Road
    TN13 3SE Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    113 Seal Hollow Road
    TN13 3SE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomSurveyor101631490002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    GREENWOOD, Patrick John Aberneithy
    24 Chestnut Avenue
    RG41 3HX Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    24 Chestnut Avenue
    RG41 3HX Wokingham
    Berkshire
    BritishChartered Accountant77514730001
    PEACOCK, Colin John
    Brock House
    60 Easthampstead Road
    RG40 2EE Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    Brock House
    60 Easthampstead Road
    RG40 2EE Wokingham
    Berkshire
    BritishSurveyor32883610012
    SILVESTER, Robert Peter, Mr.
    113 Seal Hollow Road
    TN13 3SE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    113 Seal Hollow Road
    TN13 3SE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomUnited KingdomSurveyor101631490002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GLANCEPRESS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over rent and general accounts
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 23 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All it's right, title and interest in the charged balance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 23 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 23 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 23 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over deposit account
    Creato il 14 gen 2009
    Consegnato il 23 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All it's rights in the charged balance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 23 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property known as 36/37 market place wokingham and 38/42 market place and 1-5 rose street wokingham t/n's BK216391 BK370839 and BK370840,. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over rental account
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the charged balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of rental assignment
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title benefit and interest in all rent of the properties known as 36/37 market place t/n BK216391 and 38/42 market place and 1-5 rose street wokingham t/n BK370840. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture (floating charge)
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 20 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge all property and assets present and future from time to time owned by the company or in which the company may have an interest.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 20 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed
    Creato il 24 nov 1998
    Consegnato il 10 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 29 july 1998
    Brevi particolari
    36 market place,wokingham,berkshire.BK216391.together with all buildings,erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transazioni
    • 10 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2004Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
      • Numero di pratica 2
    Deed of assignment
    Creato il 24 nov 1998
    Consegnato il 10 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from glancepress limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of glancepress limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to the chargee as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, norwich union PLC and any company which is or becomes a holding company of any such company of subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed monies by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the rights,titles,benefits and interests and whether present or future of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of 36 market place,wokingham,berkshire.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transazioni
    • 10 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of charge
    Creato il 29 lug 1998
    Consegnato il 06 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of glancepress limited (and any subsidiary undertaking or associate of any such company) (each a group member) to the chargees under the terms of the charge and on any other account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest in and to the leases of shop units at 38, 39,40,41,42, 42A and 42B market place. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited(and Any Holding Company or Subsidiary Thereof)
    Transazioni
    • 06 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of legal charge
    Creato il 29 lug 1998
    Consegnato il 06 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company (and any subsidiary undertaking or associate of any such company) (each a group company) to the chargees under the terms of the charge or in any other manner whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the north side of market place t/no;-BK36823 and the f/h land on the south east side of rose street t/no;-BK57958 together with all buildings erections and fixtures (including tenants fixtures) all improvements and additions thereto benefit of all leases floating charge over the whole of the company's property assets rights and revenues including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transazioni
    • 06 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2004Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 10 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
      • Numero di pratica 1

    GLANCEPRESS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 lug 1998Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jonathan Green
    72-75 Marylebone High Street
    London
    W1M 3AR
    Praticante
    72-75 Marylebone High Street
    London
    W1M 3AR
    2
    DataTipo
    24 nov 1998Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jonathan Green
    72-75 Marylebone High Street
    London
    W1M 3AR
    Praticante
    72-75 Marylebone High Street
    London
    W1M 3AR
    3
    DataTipo
    19 ago 2016Data prevista di scioglimento
    23 ago 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Keith Aleric Stevens
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Praticante
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    John Arthur Kirkpatrick
    Wilkins Kennedy Llp 92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Praticante
    Wilkins Kennedy Llp 92 London Street
    RG1 4SJ Reading

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0