CARDPOINT SERVICES LIMITED

CARDPOINT SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARDPOINT SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03516589
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o CARDTRONICS UK LIMITED
    Building 4, 1st Floor Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARDPOINT SERVICES TRADING AS CASHZONE LIMITED19 feb 200919 feb 2009
    CARDPOINT SERVICES LIMITED23 ott 200823 ott 2008
    MONEYBOX CORPORATION LIMITED17 gen 200017 gen 2000
    MONEY BOX CORPORATION LIMITED25 feb 199825 feb 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Cessazione della carica di Michael Edward Keller come amministratore in data 25 giu 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Christopher Brewster come amministratore in data 25 giu 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Edward Keller come segretario in data 25 giu 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mar 2015

    Stato del capitale al 03 mar 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Squire Sanders (Uk) Llp Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR England a C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Squire Patton Boggs (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House 148 Edmund Street Birmingham B3 2JR

    1 pagineAD03

    Nomina di Jana Hile come amministratore in data 15 ago 2014

    2 pagineAP01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 27 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Jeremy David Kraft come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    19 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da , Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu) Rutland House, 148 Edmund Street, Birmingham, B3 2JR in data 16 giu 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 25 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 feb 2014

    Stato del capitale al 25 feb 2014

    • Capitale: GBP 5,769,863.59
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom

    1 pagineAD02

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata

    1 pagineAD04

    Dimissioni del revisore

    3 pagineAUD

    Nomina di Mr Jeremy David Kraft come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Michael Keller come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di John Christopher Brewster come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CARDPOINT SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HILE, Jana
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    EnglandAustralian192111080001
    SIMPSON DENT, Jonathan
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Gadbrook Park
    CW9 7TW Northwich
    Davidson House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish110396210002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    English107835250001
    HOGAN, Brenda
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Segretario
    Apt 55 Sandyford View Simonsridge
    Blackglen Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Other75975040003
    KATZ, Peter David
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    Segretario
    20 Tudor Close
    IG8 0LF Woodford Green
    Essex
    British64682050001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Segretario
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    American105857220002
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Segretario
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    British42734310002
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ABERNETHY, Kieron Quinn
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    Amministratore
    2 Salisbury Place
    West Byfleet
    KT14 6SN London
    United KingdomBritish200594530001
    BEERLING, Kevin Michael
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    Amministratore
    14 Firside Grove
    DA15 8WB Sidcup
    Kent
    United KingdomBritish64677850002
    BREWSTER, John Christopher
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican181428100001
    BROWN, Neil Graeme
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Aldenham Avenue
    WD7 8HJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish49772410001
    DINSMORE, Rikki Gavin
    Aisher Way
    Riverhead
    TN13 2QS Sevenoaks
    34
    Kent
    Amministratore
    Aisher Way
    Riverhead
    TN13 2QS Sevenoaks
    34
    Kent
    United KingdomBritish137100920001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    British109659860001
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    HOLROYD, Richard Norton
    Flat 8
    37 De Vere Gardens
    W8 5AW London
    Amministratore
    Flat 8
    37 De Vere Gardens
    W8 5AW London
    British80220410001
    ISAACS, Vincent
    Denham Cottage
    41 Totteridge Common Totteridge
    N20 8LS London
    Amministratore
    Denham Cottage
    41 Totteridge Common Totteridge
    N20 8LS London
    British38705920001
    KELLER, Michael Edward
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    c/o Cardtronics Uk Limited
    Trident Place
    Mosquito Way
    AL10 9UL Hatfield
    Building 4, 1st Floor
    Hertfordshire
    England
    UsaAmerican105857220002
    KRAFT, Jeremy David
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    27
    Middlesex
    England
    United KingdomBritish71360190003
    LANIGAN, Philip Nicholas
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    120 Buckingham Road
    SK4 4RG Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish42734310002
    MALONEY, Michael John
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    Beechwood Road
    Ranelagh
    8
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandIrish161364970001
    MCNAMARA, Peter Denis
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 B Land Avenue
    AL5 4RG Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish114555600001
    MILLS, Mark Richard
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    55 Hove Road
    FY8 1XH Lytham St Annes
    Lancashire
    British10402540005
    MORGAN, Colin John
    87 Globe Wharf
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XX London
    Amministratore
    87 Globe Wharf
    205 Rotherhithe Street
    SE16 5XX London
    Irish70867300001
    MURPHY, James Timmerman
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    Amministratore
    Park Ave #10c
    Nyc
    1120
    10728 New York
    Usa
    American130237490001
    NEUBAUER, Eirion Andrew Charles
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    Amministratore
    Flat 11 Kingsley Lodge
    13 New Cavendish Street
    W1G 9UG London
    EnglandBritish116252510001
    ROBSON, Vincent Martin
    Glebe End
    Station Road, Eynsford
    DA4 0ER Dartford
    Kent
    Amministratore
    Glebe End
    Station Road, Eynsford
    DA4 0ER Dartford
    Kent
    British64602710001
    RYLAND, Stuart Antony
    5 Yeading Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9RL Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    5 Yeading Avenue
    Rayners Lane
    HA2 9RL Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish74367340001
    SAXTON, Paul
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    Amministratore
    19 Ashdale Close
    ST7 2EN Alsager
    Staffordshire
    British121726830001
    SMYTH, Peter Francis
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Amministratore
    Flat 2 62 Queens Gate
    SW7 5JP London
    Irish63863190002
    STANLEY, Paul Robert
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    70 Wolmer Gardens
    HA8 8DQ Edgware
    Middlesex
    British58251370003
    STIMPSON, Andrew David
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    Amministratore
    4 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    EnglandBritish99393670001
    TURRELL, Mary Margaret
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    1 St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    Cheshire
    EnglandBritish92654710001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    CARDPOINT SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A confirmatory security agreement
    Creato il 09 apr 2010
    Consegnato il 13 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 13 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A second ranking share pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there
    Creato il 05 feb 2010
    Consegnato il 22 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from an obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Existing pledges means the pledges constituted pursuant to the existing share pledge agreement, shares. The pledges include the present and future rights to receive dividends and liquidation proceeds, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 22 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 05 dic 2007
    Consegnato il 15 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent and each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 15 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge agreement
    Creato il 18 mag 2007
    Consegnato il 02 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The existing shares and the future shares together with all ancillary rights and claims, dividends payable in relation to the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Agent or the Security Trustee). the Royalbank of Scotland the 'Original Pledgees'
    Transazioni
    • 02 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Syndicated debenture
    Creato il 13 mar 2006
    Consegnato il 22 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    01. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Trustees for Thebeneficiaries
    Transazioni
    • 22 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Accession deed to an intercreditor deed dated 25 august 2005 and
    Creato il 19 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Until after the discharge date if the additional obligor receives or recovers any intra-group recoveries except for any permitted intra-group payments it shall pay all such assets and monies received or recovered by it (the turnover receipts) to the security trustee for application in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. Pending such payment to the security trustee the additional obligor shall hold on trust for application by the security trustee in accordance with clause 10 (application of recoveries) of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 lug 2005
    Consegnato il 15 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All land (other than the short l/h land) rights in atm equipment, all other plant, machinery, vehicles and other equipment used in a business, investments; any contract entered into after the date of the debenture which is designated as a key contract by moneybox PLC and the chargee, any account, all copyright, any monetary claim of any kind and goodwill and uncalled capital, floating charge the company's undertaking and all its present and future assets;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 15 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 set 2004
    Consegnato il 09 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 set 2004
    Consegnato il 03 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 03 giu 2003
    Consegnato il 21 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,100,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    52 authomated teller machines.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 21 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of chattels
    Creato il 03 giu 2003
    Consegnato il 19 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,100,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A number of automated teller machines situated at the locations together with the benefit of a licence to retain the atms at the locations. The benefit of all contracts and agreements relating to the atms. Any goodwill in the atms. The benefit of any insurances in relating to the atms.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 19 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0