DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED

DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03517905
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O BEGBIES TRAYNOR
    340 Deansgate
    M3 4LY Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUNLOP HEYWOOD LORENZ LIMITED18 mag 200118 mag 2001
    DUNLOP HEYWOOD & CO LIMITED08 ott 199808 ott 1998
    IBIS (419) LIMITED26 feb 199826 feb 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2005

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    1 pagine4.43

    legacy

    1 pagine287

    Nomina di un liquidatore

    1 pagine4.31

    Ordine del tribunale di liquidazione

    1 pagineCOCOMP

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    6 pagine395

    legacy

    1 pagine403b

    legacy

    1 pagine403b

    legacy

    3 pagine395

    Risoluzioni

    Resolutions
    19 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BELLIS, Juliet Mary Susan
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    Segretario
    4 Grange Hill
    SE25 6SX London
    BritishSolicitor69991160002
    DAVIS, Nigel Peter
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    6 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishAccountant93673010002
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Amministratore
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    EnglandBritishChartered Secretary11498320001
    DAVIS, Nigel Peter
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    66 Redway Drive
    TW2 7NW Twickenham
    Middlesex
    BritishAccountant93673010001
    DAVIS, Paul Malcolm
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant30526830004
    TSD SECRETARIES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Segretario nominato
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    900007450001
    ALDER, Frank
    22 Menlove Gardens South
    L18 2EL Liverpool
    Amministratore
    22 Menlove Gardens South
    L18 2EL Liverpool
    BritishSurveyor62975520001
    ARMITAGE, Stephen Hubert
    The Glade
    Kingswood
    KT20 6JJ Tadworth
    Briarwood
    Surrey
    Amministratore
    The Glade
    Kingswood
    KT20 6JJ Tadworth
    Briarwood
    Surrey
    United KingdomBritishSurveyor29773030001
    ASHWOOD, Warren Lee
    7 Pilgrim Close
    Park St.
    AL2 2JD St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Pilgrim Close
    Park St.
    AL2 2JD St. Albans
    Hertfordshire
    BritishSurveyor68986060002
    BOUSFIELD, Richard John
    19 Jackson Street
    SK8 2AU Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    19 Jackson Street
    SK8 2AU Cheadle
    Cheshire
    BritishChartered Surveyor104442340001
    BRAY, Anthony John
    25 Chandos Road
    M21 0SS Chorlton
    Manchester
    Amministratore
    25 Chandos Road
    M21 0SS Chorlton
    Manchester
    BritishSurveyor75694600001
    BROCKLEHURST, Alastair Robin
    Courtyard House
    Hobb Lane Moore
    WA4 5QS Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Courtyard House
    Hobb Lane Moore
    WA4 5QS Warrington
    Cheshire
    BritishSurveyor83971190001
    BUNTING, Ross
    5 Vaudrey Drive
    Cheadle Hulme
    SK8 5LR Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    5 Vaudrey Drive
    Cheadle Hulme
    SK8 5LR Stockport
    Cheshire
    BritishSurveyor60887880001
    BURGESS, John
    Keys Cottage Main Street
    Bolton By Bowland
    BB7 4NW Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Keys Cottage Main Street
    Bolton By Bowland
    BB7 4NW Clitheroe
    Lancashire
    BritishSurveyor61002140001
    COOKE, Stephen Malcolm
    Lowood
    Newton In Bowland
    BB7 3DZ Clitheroe
    Lancashire
    Amministratore
    Lowood
    Newton In Bowland
    BB7 3DZ Clitheroe
    Lancashire
    BritishSurveyor59315260001
    DAVIS, Paul Malcolm
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    Amministratore
    3 Church Close
    WD7 8BJ Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant30526830004
    DONELLY GALLAGHER, Hugh Peter
    The Moorings 7 Barnfield Flixton
    Urmston
    M41 9EW Manchester
    Amministratore
    The Moorings 7 Barnfield Flixton
    Urmston
    M41 9EW Manchester
    BritishSurveyor60887070001
    DYSON, Robert William
    14 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    Amministratore
    14 Briar Walk
    Putney
    SW15 6UD London
    United KingdomBritishSurveyor24554680002
    ECCLES, Christopher John Roy
    11 Montague Road
    Ealing
    W13 8HA London
    Amministratore
    11 Montague Road
    Ealing
    W13 8HA London
    BritishChartered Surveyor41032220002
    FALLON, Geoffrey Trevor
    20 Askew Drive
    Spencers Wood
    RG7 1HG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    20 Askew Drive
    Spencers Wood
    RG7 1HG Reading
    Berkshire
    BritishSurveyor66085850002
    FOREMAN, Neil Richard Oates
    7 High Street
    OX49 5PZ Watlington
    Oxfordshire
    Amministratore
    7 High Street
    OX49 5PZ Watlington
    Oxfordshire
    EnglandBritishSurveyor108536420001
    FROSHAUG, Christopher Alan
    12 Saint Catherines Road
    RH10 3TA Crawley
    West Sussex
    Amministratore
    12 Saint Catherines Road
    RH10 3TA Crawley
    West Sussex
    BritishDirector76571190001
    GOODING, Jonathan Michael
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    Amministratore
    13 Albany Street
    NW1 4DX London
    United KingdomBritishChartered Surveyor16684130002
    GORDON, Richard John
    44 Westgate
    Hale
    WA15 9AZ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    44 Westgate
    Hale
    WA15 9AZ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishSurveyor41159660001
    HORDER, Jane
    Flat 3 36 Elsworthy Road
    NW3 3DL London
    Amministratore
    Flat 3 36 Elsworthy Road
    NW3 3DL London
    EnglandEnglishSurveyor60268720001
    JAMES, Simon Nicholas
    The Old Vicarage
    24 Darley Avenue
    M20 2YD Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    24 Darley Avenue
    M20 2YD Manchester
    Lancashire
    BritishSurveyor65239760001
    JONES, Philip Neil
    122 Oldfield Road
    WA14 4BJ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    122 Oldfield Road
    WA14 4BJ Altrincham
    Cheshire
    BritishChartered Surveyor33922130002
    KAHN, David Philip
    1 Gurney Drive
    East Finchley
    N2 0DF London
    Amministratore
    1 Gurney Drive
    East Finchley
    N2 0DF London
    BritishEstate Agent54880020001
    KING, Michael Augustine
    2 Kingsley Avenue
    SK9 4EN Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    2 Kingsley Avenue
    SK9 4EN Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishSurveyor47445430001
    LEGGETT, Graeme Barrie
    17 Suffolk Drive
    Weybrook Park
    GU4 7FD Burpham Guildford
    Surrey
    Amministratore
    17 Suffolk Drive
    Weybrook Park
    GU4 7FD Burpham Guildford
    Surrey
    BritishSurveyor73722600001
    LIDGLEY, Paul Philip
    Station House
    Old Burghclere
    RG20 9NT Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Station House
    Old Burghclere
    RG20 9NT Newbury
    Berkshire
    BritishSurveyor60886850001
    LIPMAN, Larry Glenn
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    Amministratore
    12 Park St James
    Prince Albert Road
    NW8 7LE St Johns Wood
    EnglandBritishDirector62622410007
    LORENZ, Anthony Michael
    Flat 1 12-14 Reeves Mews
    W1K 2EG London
    Amministratore
    Flat 1 12-14 Reeves Mews
    W1K 2EG London
    EnglandBritishEstate Agent76126010002
    MCGARRY, Ian Mark
    10 Nomansland
    AL4 8EJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    10 Nomansland
    AL4 8EJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    BritishChartered Surveyor96614800001
    MILLAR MILLS, John Anthony
    8 Knutsford Road
    SK9 6JA Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    8 Knutsford Road
    SK9 6JA Wilmslow
    Cheshire
    BritishFinance Director49333640001

    DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of assignment
    Creato il 12 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the assignors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned rights and benefits being the rights and benefits of the assignors under the policy including (without limitation) those arising out of the judgment and the settlement agreement all and any rights and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of indemnity and charge
    Creato il 06 lug 2007
    Consegnato il 17 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the company's interest in the claims, causes of action and rights of the company in relation to (a) claims for damages against the brokers of the primary professional indemnity insurance cover and excess professional indemnity insurance cover (the "cover") and (b) claims for an indemnity against the underwriters of the cover (together the "broker claims"). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Erinaceous Group PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 18 nov 2004
    Consegnato il 24 nov 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 06 mar 2002
    Consegnato il 14 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC, as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 09 nov 1999
    Consegnato il 19 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company (as therein defined) to the chargee whether pursuant to the guarantee (as therein defined) or otherwise on any account whatsoever
    Brevi particolari
    340 gray's inn road london WC1X 8BJ t/n NGL107046. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    DUNLOP HAYWARDS (DHL) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 mar 2015Conclusione della liquidazione
    23 gen 2008Data della petizione
    12 mag 2008Inizio della liquidazione
    23 giu 2015Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praticante
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Paul Stanley
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly
    Praticante
    Begbies Traynor
    340 Deansgate
    Manchester
    M3 4ly

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0