RETAIL PGRL LIMITED
Panoramica
Nome della società | RETAIL PGRL LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03518606 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RETAIL PGRL LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova RETAIL PGRL LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Capital Link Windsor Road CF24 5NG Cardiff Wales |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RETAIL PGRL LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PEACOCK GROUP RETAIL LIMITED | 18 giu 1998 | 18 giu 1998 |
GLASSWILD LIMITED | 27 feb 1998 | 27 feb 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RETAIL PGRL LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 03 apr 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per RETAIL PGRL LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed peacock group retail LIMITED\certificate issued on 29/02/12 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Nomina di Mr Roy George Ellis come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Killick come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 03 apr 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Atlantic House Tyndall Street Cardiff CF10 4PS in data 31 ago 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 mar 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 29 mar 2008 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2007 | 7 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2006 | 11 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a |
Chi sono gli amministratori di RETAIL PGRL LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLIS, Roy George | Segretario | 57 St Lawrence Park NP16 6DP Chepstow Gwent | British | 116788900001 | ||||||
BURNS, Neil Anthony | Amministratore | 8 Ffordd Gwern St. Fagans CF5 6PB Cardiff | Wales | British | Group Operations Director | 62596180004 | ||||
ELLIS, Roy George | Amministratore | Windsor Road CF24 5NG Cardiff Capital Link Wales | Wales | British | Director | 161784490001 | ||||
KIRK, Richard Stanley, Mr. | Amministratore | Palace Gardens Terrace W8 4RP London 34 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 54276260003 | ||||
KILLICK, Michael David | Segretario | 1 Fryth Wood NP16 6DU Chepstow Monmouthshire | British | 75927820002 | ||||||
WIGLEY, Islwyn Thomas | Segretario | 22 Windsor Road Radyr CF4 8BQ Cardiff | British | 57629920001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BRYANT, Keith Ralph | Amministratore | Claremont Tidenham NP16 7JF Chepstow | United Kingdom | British | Director | 54831150003 | ||||
KILLICK, Michael David | Amministratore | 1 Fryth Wood NP16 6DU Chepstow Monmouthshire | Wales | British | Director | 75927820002 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
RETAIL PGRL LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 23 gen 2006 Consegnato il 31 gen 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in the non-consent mortgaged property the additional property the tangible moveable property the accounts the intellectual property the charged intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares and all dividends. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture between the company, the chargors (as defined) and the governor and company of the bank of scotland (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) | Creato il 02 dic 1999 Consegnato il 17 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Amendment variation guarantee and security deed | Creato il 27 ago 1998 Consegnato il 11 set 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any of the financing documents and under the debenture | |
Brevi particolari Property k/a 6-7 cibi walk abergavenny t/no WA424980 41-44 church street abertillery t/no WA414286 59-61 market street ashby-de-la-zouche t/no LT183820 (and all the other properties listed) together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0