RETAIL PGRL LIMITED

RETAIL PGRL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRETAIL PGRL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03518606
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RETAIL PGRL LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova RETAIL PGRL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Capital Link
    Windsor Road
    CF24 5NG Cardiff
    Wales
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RETAIL PGRL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PEACOCK GROUP RETAIL LIMITED18 giu 199818 giu 1998
    GLASSWILD LIMITED27 feb 199827 feb 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di RETAIL PGRL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al03 apr 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per RETAIL PGRL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 apr 2012

    Stato del capitale al 02 apr 2012

    • Capitale: GBP 10,000,000
    SH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed peacock group retail LIMITED\certificate issued on 29/02/12
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 27 feb 2012

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Nomina di Mr Roy George Ellis come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Killick come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 03 apr 2010

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Atlantic House Tyndall Street Cardiff CF10 4PS in data 31 ago 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 27 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 mar 2009

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 29 mar 2008

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2006

    11 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di RETAIL PGRL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLIS, Roy George
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    Segretario
    57 St Lawrence Park
    NP16 6DP Chepstow
    Gwent
    British116788900001
    BURNS, Neil Anthony
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    Amministratore
    8 Ffordd Gwern
    St. Fagans
    CF5 6PB Cardiff
    WalesBritishGroup Operations Director62596180004
    ELLIS, Roy George
    Windsor Road
    CF24 5NG Cardiff
    Capital Link
    Wales
    Amministratore
    Windsor Road
    CF24 5NG Cardiff
    Capital Link
    Wales
    WalesBritishDirector161784490001
    KIRK, Richard Stanley, Mr.
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    Amministratore
    Palace Gardens Terrace
    W8 4RP London
    34
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector54276260003
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Segretario
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    British75927820002
    WIGLEY, Islwyn Thomas
    22 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    Segretario
    22 Windsor Road
    Radyr
    CF4 8BQ Cardiff
    British57629920001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRYANT, Keith Ralph
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    Amministratore
    Claremont
    Tidenham
    NP16 7JF Chepstow
    United KingdomBritishDirector54831150003
    KILLICK, Michael David
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    Amministratore
    1 Fryth Wood
    NP16 6DU Chepstow
    Monmouthshire
    WalesBritishDirector75927820002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    RETAIL PGRL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 gen 2006
    Consegnato il 31 gen 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the non-consent mortgaged property the additional property the tangible moveable property the accounts the intellectual property the charged intellectual property any goodwill and rights in relation to the uncalled capital the investments the shares and all dividends. By way of floating charge all assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners L.P. as Security Trustees for and on Behalf of the Securedparties
    Transazioni
    • 31 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture between the company, the chargors (as defined) and the governor and company of the bank of scotland (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined)
    Creato il 02 dic 1999
    Consegnato il 17 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the lenders (or any of them) under each or any of the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders (As Defined)
    Transazioni
    • 17 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Amendment variation guarantee and security deed
    Creato il 27 ago 1998
    Consegnato il 11 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any of the financing documents and under the debenture
    Brevi particolari
    Property k/a 6-7 cibi walk abergavenny t/no WA424980 41-44 church street abertillery t/no WA414286 59-61 market street ashby-de-la-zouche t/no LT183820 (and all the other properties listed) together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0