RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED

RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03519669
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3AB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GRANTCHESTER PROPERTIES (CATFORD) LIMITED23 feb 199923 feb 1999
    GRANTCHESTER PROPERTIES (DUNDEE) LIMITED10 mar 199810 mar 1998
    INTERCEDE 1302 LIMITED02 mar 199802 mar 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew John Jackson come amministratore in data 23 ago 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 29 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 giu 2016

    Stato del capitale al 29 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew John Jackson il 12 ott 2015

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Michael Hannigan il 12 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Brian Watt il 12 ott 2015

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Graham Paine il 08 ott 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Paolo Alonzi il 08 ott 2015

    1 pagineCH03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    12 pagineAA

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB

    1 pagineAD04

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 lug 2015

    Stato del capitale al 14 lug 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 lug 2014

    Stato del capitale al 28 lug 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 lug 2013

    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Chi sono gli amministratori di RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ALONZI, Paolo
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Segretario
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Italian113225330001
    HANNIGAN, Robert Michael
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish81510590004
    PAINE, David Graham
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    ScotlandBritish156455760001
    WATT, Mark Brian
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish85845500002
    EVANS, Michael
    Willowtyne
    Victoria Road
    EH41 4DJ Haddington
    East Lothian
    Segretario
    Willowtyne
    Victoria Road
    EH41 4DJ Haddington
    East Lothian
    British98652120001
    HAYDON, Stuart John
    156 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    Segretario
    156 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    British3175210001
    HOLLOCKS, Ian Michael
    22 Fairholme Avenue
    RM2 5UU Gidea Park
    Essex
    Segretario
    22 Fairholme Avenue
    RM2 5UU Gidea Park
    Essex
    British61055270001
    REITH, Julie Katharine
    Flat 3f2 47 Brunswick Road
    EH7 5PD Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    Flat 3f2 47 Brunswick Road
    EH7 5PD Edinburgh
    Midlothian
    British112039220001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Segretario
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    38565160001
    ALFORD, Nicholas Brian Treseder
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Pines
    North Road
    HP4 3DX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Great BritainBritish126970360001
    ALONZI, Paolo
    20 Rattray Grove
    EH10 5TL Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    20 Rattray Grove
    EH10 5TL Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomItalian113225330001
    ATKINS, David John
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    Amministratore
    60 Dukes Wood Drive
    SL9 7LF Gerrards Cross
    The Barn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish144036070001
    BAKER, Michael John
    18 Seaton Close
    Lynden Gate Putney Heath
    SW15 3TJ London
    Amministratore
    18 Seaton Close
    Lynden Gate Putney Heath
    SW15 3TJ London
    British77729120001
    BYWATER, John Andrew
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Craigens
    Hill Foot Lane Burn Bridge
    HG3 1NT Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritish71820020003
    COLE, Peter William Beaumont
    Walnut Tree Farm
    Walnut Tree Road Pirton
    SG5 3PX Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    Walnut Tree Farm
    Walnut Tree Road Pirton
    SG5 3PX Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish51145990001
    EVANS, Christopher Mark Stephen
    12 Criffel Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4AZ London
    Amministratore
    12 Criffel Avenue
    Streatham Hill
    SW2 4AZ London
    EnglandBritish71333340001
    HARDIE, Nicholas Alan Scott
    Albert Square
    SW8 1BS London
    21
    Amministratore
    Albert Square
    SW8 1BS London
    21
    EnglandBritish56627250001
    HARRIS, Iain Farlane Sim
    1 Red Lion Cottages
    WD25 8BB Aldenham
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Red Lion Cottages
    WD25 8BB Aldenham
    Hertfordshire
    EnglandBritish56363000001
    HEWSON, Andrew Nicholas
    Abesters
    Fernden Lane Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Abesters
    Fernden Lane Blackdown
    GU27 3BS Haslemere
    Surrey
    British8607090005
    HUBERMAN, Paul Laurence
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    Amministratore
    15 Wildwood Road
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 6UL London
    EnglandBritish3470530003
    JACKSON, Andrew John
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish83130180001
    MCGUIRE, Martin Anton
    4 Gilmour Road
    EH16 5NF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    4 Gilmour Road
    EH16 5NF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish46513600001
    REEVES, Barbara
    Flat 2 24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    Amministratore
    Flat 2 24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    United KingdomBritish75639030006
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill, Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    Amministratore
    Hillfield
    Gorse Hill, Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    British70341190001
    WALTON, Timothy Paul
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    Amministratore
    Ivy House Church Row
    Meole Brace
    SY3 9EY Shrewsbury
    Shropshire
    United KingdomBritish59971310002
    WHIGHT, Paul James
    24d Thameside
    RG9 2LJ Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    24d Thameside
    RG9 2LJ Henley-On-Thames
    Oxfordshire
    British110745030002
    WRIGHT, Geoffrey Harcroft
    Michaelmas House
    4 The Riddings
    CR3 6DW Caterham
    Surrey
    Amministratore
    Michaelmas House
    4 The Riddings
    CR3 6DW Caterham
    Surrey
    British8585700001

    RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 08 mag 2000
    Consegnato il 17 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of (I) the chargor and (ii) gel to any of the finance parties under or pursuant to the financing documents (all terms as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank (London Branch) (the "Securitytrustee", Which Expression Shall Include All Successor Agents Appointed from Time to Time)
    Transazioni
    • 17 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 apr 2000
    Consegnato il 17 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    For property details see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westdeutsche Immobilienbank (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 17 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0