RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03519669 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GRANTCHESTER PROPERTIES (CATFORD) LIMITED | 23 feb 1999 | 23 feb 1999 |
| GRANTCHESTER PROPERTIES (DUNDEE) LIMITED | 10 mar 1998 | 10 mar 1998 |
| INTERCEDE 1302 LIMITED | 02 mar 1998 | 02 mar 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew John Jackson come amministratore in data 23 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 29 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew John Jackson il 12 ott 2015 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Michael Hannigan il 12 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Brian Watt il 12 ott 2015 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per David Graham Paine il 08 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Paolo Alonzi il 08 ott 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 12 pagine | AA | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB | 1 pagine | AD04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALONZI, Paolo | Segretario | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | Italian | 113225330001 | ||||||
| HANNIGAN, Robert Michael | Amministratore | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 81510590004 | |||||
| PAINE, David Graham | Amministratore | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | Scotland | British | 156455760001 | |||||
| WATT, Mark Brian | Amministratore | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 85845500002 | |||||
| EVANS, Michael | Segretario | Willowtyne Victoria Road EH41 4DJ Haddington East Lothian | British | 98652120001 | ||||||
| HAYDON, Stuart John | Segretario | 156 Woodland Way BR4 9LU West Wickham Kent | British | 3175210001 | ||||||
| HOLLOCKS, Ian Michael | Segretario | 22 Fairholme Avenue RM2 5UU Gidea Park Essex | British | 61055270001 | ||||||
| REITH, Julie Katharine | Segretario | Flat 3f2 47 Brunswick Road EH7 5PD Edinburgh Midlothian | British | 112039220001 | ||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 38565160001 | |||||||
| ALFORD, Nicholas Brian Treseder | Amministratore | The Pines North Road HP4 3DX Berkhamsted Hertfordshire | Great Britain | British | 126970360001 | |||||
| ALONZI, Paolo | Amministratore | 20 Rattray Grove EH10 5TL Edinburgh Midlothian | United Kingdom | Italian | 113225330001 | |||||
| ATKINS, David John | Amministratore | 60 Dukes Wood Drive SL9 7LF Gerrards Cross The Barn Buckinghamshire | United Kingdom | British | 144036070001 | |||||
| BAKER, Michael John | Amministratore | 18 Seaton Close Lynden Gate Putney Heath SW15 3TJ London | British | 77729120001 | ||||||
| BYWATER, John Andrew | Amministratore | Craigens Hill Foot Lane Burn Bridge HG3 1NT Harrogate North Yorkshire | England | British | 71820020003 | |||||
| COLE, Peter William Beaumont | Amministratore | Walnut Tree Farm Walnut Tree Road Pirton SG5 3PX Hitchin Hertfordshire | England | British | 51145990001 | |||||
| EVANS, Christopher Mark Stephen | Amministratore | 12 Criffel Avenue Streatham Hill SW2 4AZ London | England | British | 71333340001 | |||||
| HARDIE, Nicholas Alan Scott | Amministratore | Albert Square SW8 1BS London 21 | England | British | 56627250001 | |||||
| HARRIS, Iain Farlane Sim | Amministratore | 1 Red Lion Cottages WD25 8BB Aldenham Hertfordshire | England | British | 56363000001 | |||||
| HEWSON, Andrew Nicholas | Amministratore | Abesters Fernden Lane Blackdown GU27 3BS Haslemere Surrey | British | 8607090005 | ||||||
| HUBERMAN, Paul Laurence | Amministratore | 15 Wildwood Road Hampstead Garden Suburb NW11 6UL London | England | British | 3470530003 | |||||
| JACKSON, Andrew John | Amministratore | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 83130180001 | |||||
| MCGUIRE, Martin Anton | Amministratore | 4 Gilmour Road EH16 5NF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 46513600001 | |||||
| REEVES, Barbara | Amministratore | Flat 2 24 Bracknell Gardens NW3 7ED London | United Kingdom | British | 75639030006 | |||||
| RICH, Michael William | Amministratore | Hillfield Gorse Hill, Farningham DA4 0JU Dartford Kent | British | 70341190001 | ||||||
| WALTON, Timothy Paul | Amministratore | Ivy House Church Row Meole Brace SY3 9EY Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 59971310002 | |||||
| WHIGHT, Paul James | Amministratore | 24d Thameside RG9 2LJ Henley-On-Thames Oxfordshire | British | 110745030002 | ||||||
| WRIGHT, Geoffrey Harcroft | Amministratore | Michaelmas House 4 The Riddings CR3 6DW Caterham Surrey | British | 8585700001 |
RAVENSBOURNE RETAIL PARK LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 08 mag 2000 Consegnato il 17 mag 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of (I) the chargor and (ii) gel to any of the finance parties under or pursuant to the financing documents (all terms as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 12 apr 2000 Consegnato il 17 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari For property details see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0