JPT 8 LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJPT 8 LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03520231
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JPT 8 LTD?

    • (7011) /

    Dove si trova JPT 8 LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Rok Centre Guardian Road
    Exeter Business Park
    EX1 3PD Exeter
    Devon
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JPT 8 LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROKEAGLE LAND LIMITED18 feb 200318 feb 2003
    ROCKEAGLE LAND LIMITED02 mar 199802 mar 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di JPT 8 LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per JPT 8 LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Stuart Longbottom come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Julian Turnbull come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Ross Christie come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 mar 2010

    Stato del capitale al 15 mar 2010

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di Garvis Snook come amministratore

    2 pagineTM01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed rokeagle land LIMITED\certificate issued on 02/01/10
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name02 gen 2010

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 18 dic 2009

    RES15

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    1 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    1 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    1 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di JPT 8 LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BENSON, Nicholas Mark Richard
    Tale End
    Toadpit Lane West Hill
    EX11 1TR Ottery St Mary
    Devon
    Segretario
    Tale End
    Toadpit Lane West Hill
    EX11 1TR Ottery St Mary
    Devon
    BritishSolicitor57405140001
    GOODES, Paul James
    Mamhead Court
    Mamhead
    EX6 8HX Exeter
    Devon
    Segretario
    Mamhead Court
    Mamhead
    EX6 8HX Exeter
    Devon
    British91525690001
    KAY, Harry, Dr
    Mamhead House
    Mamhead
    EX6 8HD Exeter
    Devon
    Segretario
    Mamhead House
    Mamhead
    EX6 8HD Exeter
    Devon
    BritishRetired35528930001
    TURNBULL, Julian Patrick
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    Segretario
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    English11548360002
    CDF SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    188/196 Old Street
    EC1V 9FR London
    Segretario nominato
    188/196 Old Street
    EC1V 9FR London
    900014680001
    BAILEY, Michael William John
    1 Biddington Way
    EX14 2GU Honiton
    Devon
    Amministratore
    1 Biddington Way
    EX14 2GU Honiton
    Devon
    BritishAccountant104839850001
    CHRISTIE, Ross Arneil
    Whichway House 149 Marine Drive
    Rottingdean
    BN2 7GU Brighton
    East Sussex
    Amministratore
    Whichway House 149 Marine Drive
    Rottingdean
    BN2 7GU Brighton
    East Sussex
    EnglandBritishFinancial Controller106468680002
    HOLE, Nicholas Ian
    Beech Trees Lane
    TQ12 5TW Ipplepen
    Windmill Brake
    Devon
    Amministratore
    Beech Trees Lane
    TQ12 5TW Ipplepen
    Windmill Brake
    Devon
    United KingdomBritishSurveyor128347270001
    KAY, Harry, Dr
    Mamhead House
    Mamhead
    EX6 8HD Exeter
    Devon
    Amministratore
    Mamhead House
    Mamhead
    EX6 8HD Exeter
    Devon
    BritishRetired35528930001
    KAY, Mark Russell
    Mamhead Court
    Mamhead
    EX6 8HX Exeter
    Amministratore
    Mamhead Court
    Mamhead
    EX6 8HX Exeter
    BritishSurveyor1472550001
    LONGBOTTOM, Stuart Charles Donald
    Craigvar Peel Green
    BD23 4LB Hellifield
    North Yorkshire
    Amministratore
    Craigvar Peel Green
    BD23 4LB Hellifield
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector152569170001
    MORSE, Stephen Andrew
    Bell Orchard
    Bourton Road
    TQ9 5BG Totnes
    Devon
    Amministratore
    Bell Orchard
    Bourton Road
    TQ9 5BG Totnes
    Devon
    BritishSolicitor34646040002
    SNOOK, Garvis David
    Sloane Gardens
    SW1W 8EB London
    13
    Amministratore
    Sloane Gardens
    SW1W 8EB London
    13
    EnglandBritishChief Executive70647210004
    TITHERIDGE, Timothy John
    40 Kivernell Road
    SO41 0PQ Milford On Sea
    Hampshire
    Amministratore
    40 Kivernell Road
    SO41 0PQ Milford On Sea
    Hampshire
    EnglandBritishDirector161946630001
    CDF FORMATIONS LIMITED
    188/196 Old Street
    EC1V 9FR London
    Amministratore delegato nominato
    188/196 Old Street
    EC1V 9FR London
    900014670001

    JPT 8 LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 14 mag 2003
    Consegnato il 24 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the north west of hart close pill north somerset t/n ST198765. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 apr 2001
    Consegnato il 28 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at matford park exeter devon and land at coifton road marsh barton exeter devon t/no. DN277342 and DN441187.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 14 feb 2001
    Consegnato il 16 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the south side of marsh lane north petherton bridgwater.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transazioni
    • 16 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 14 feb 2001
    Consegnato il 16 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Site n langage business park plympton plymouth.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transazioni
    • 16 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 14 feb 2001
    Consegnato il 16 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Site m pynes hill office campus exeter.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transazioni
    • 16 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 gen 2001
    Consegnato il 16 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being part of site P2 langage office campus plympton plymouth part t/no.DN339939 together with all buildings and fixtures (including trade and tenants fixtures) at any time thereon.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 16 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 12 nov 1999
    Consegnato il 16 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north side of bridge road exminster otherwise k/a land at matford park exeter devon t/no;-DN277342 together with all buildings and fixtures thereon goodwill and benefit of all insurance policies relating to the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transazioni
    • 16 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 lug 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 07 lug 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Subordination deed made between the company and rockeagle village shopping limited(rvsl)(as borrowers) the bank (as senior creditor) and the company,rockeagle limited (rl) and rvsl (as junior creditors,each a junior creditor)
    Creato il 17 apr 1998
    Consegnato il 23 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from each of the company rvsl and rl to the chargee under or in connection with the rll documents and the rvsl documents
    Brevi particolari
    All present and future liabilities of each of the company and rvsl to all or any of the company,rl and/or rvsl,whether pursuant to the loan agreement dated 17 april 1998 between the company and rl providing an unsecured interest free loan in the principal amount of £3,240,000,any inter-company loan or otherwise.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank Austria Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 23 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security deed
    Creato il 17 apr 1998
    Consegnato il 23 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or in connection with-(i) the facility agreement.(ii) the deed.(iii) the subordination deed.(iv) any interest rate swap,cap or other arrangement.(v) the guarantee.(vi)the guarantee.(vii) the mortgage of shares.(viii) an assignment of key-man assurance.any other documents so designated by the bank (together the finance documents)
    Brevi particolari
    Inclusive of f/h property on the north side of bridge road exminster t/no DN277342 on the east side of bad homburg way matford t/no DN363333 and to the north side of bridge road exminster t/no 375760. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank Austria Aktiengesellschaft
    Transazioni
    • 23 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 1990
    Acquisito il 12 gen 2001
    Consegnato il 30 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £509,254.16 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Site P2 langage office campus plympton plymouth.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust Pls
    Transazioni
    • 30 gen 2001Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 20 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 nov 1989
    Acquisito il 12 gen 2001
    Consegnato il 31 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £509,254.16 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Sites h & m langage office campus plympton plymouth.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust PLC
    Transazioni
    • 31 gen 2001Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 20 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0