ROWES MOTOR COMPANY LIMITED

ROWES MOTOR COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROWES MOTOR COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03520420
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ROWES MOTOR COMPANY LIMITED?

    • Commercio al dettaglio di parti e accessori per autoveicoli (45320) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova ROWES MOTOR COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    St Martin'S House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ROWES MOTOR COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ST. JAMES'S MOTOR COMPANY LIMITED02 mar 199802 mar 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROWES MOTOR COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ROWES MOTOR COMPANY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ROWES MOTOR COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagine4.72

    Indirizzo della sede legale modificato da * Houndmills Autoplaza Aldermaston Road South Basingstoke Hampshire RG21 6YL* in data 07 nov 2013

    1 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    4 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    15 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 01 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 ago 2013

    Stato del capitale al 07 ago 2013

    • Capitale: GBP 125,000
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    14 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Nomina di Mark Poole come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Obs 24 Llp come amministratore

    3 pagineAP02

    Nomina di Rjp Secretaries Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Cessazione della carica di Gavin Walker come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Anthony Wickins come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Poole come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    18 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Gavin Robert Walker come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Derek Morgan come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Richard Poole come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Mortimer come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di ROWES MOTOR COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RJP SECRETARIES LIMITED
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2989995
    61999120002
    POOLE, Mark Richard
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    St Martin's House
    Middlesex
    Amministratore
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    St Martin's House
    Middlesex
    EnglandBritish174874030001
    OBS 24 LLP
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneOC374115
    170559870001
    ELVIDGE, Christopher Edric David
    80 Beestonfields Drive
    NG9 3TD Bramcote
    Nottinghamshire
    Segretario
    80 Beestonfields Drive
    NG9 3TD Bramcote
    Nottinghamshire
    British91249380001
    MORTIMER, Andrew Paul James
    Northweald Lane
    KT2 5GL Kingston Upon Thames
    23
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Northweald Lane
    KT2 5GL Kingston Upon Thames
    23
    Surrey
    United Kingdom
    British134750630001
    POOLE, Mark Richard
    Aldermaston Road South
    RG21 6YL Basingstoke
    Houndmills Autoplaza
    Hampshire
    Segretario
    Aldermaston Road South
    RG21 6YL Basingstoke
    Houndmills Autoplaza
    Hampshire
    163650710001
    SMITH, David Peter Ansley
    Copped Hall Barn
    Okehurst Lane
    RH14 9HR Billinghurst
    West Sussex
    Segretario
    Copped Hall Barn
    Okehurst Lane
    RH14 9HR Billinghurst
    West Sussex
    British2541030004
    WICKINS, Michael Anthony
    Hazelwood Lodge
    Hennock
    TQ139PU Bovey Tracey
    Devon
    Segretario
    Hazelwood Lodge
    Hennock
    TQ139PU Bovey Tracey
    Devon
    British114468860007
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ELVIDGE, Christopher Edric David
    80 Beestonfields Drive
    NG9 3TD Bramcote
    Nottinghamshire
    Amministratore
    80 Beestonfields Drive
    NG9 3TD Bramcote
    Nottinghamshire
    British91249380001
    MORGAN, Derek Anthony
    The Homestead
    Shenley Church End
    MK5 6DJ Milton Keynes
    Amministratore
    The Homestead
    Shenley Church End
    MK5 6DJ Milton Keynes
    United KingdomBritish51781140002
    SPAETT, Christian Rainer
    West Lodge
    Ashwell
    TA19 9DY Ilminster
    Somerset
    Amministratore
    West Lodge
    Ashwell
    TA19 9DY Ilminster
    Somerset
    German79239080002
    WALKER, Gavin Robert
    Highcliffe Close
    EX12 2QA Seaton
    Highcliff Lodge
    Devon
    United Kingdom
    Amministratore
    Highcliffe Close
    EX12 2QA Seaton
    Highcliff Lodge
    Devon
    United Kingdom
    United KingdomBritish128424740001
    WATSON, Kevin Terry
    3 Sea Drive
    Felpham
    PO22 7NB Bognor Regis
    West Sussex
    Amministratore
    3 Sea Drive
    Felpham
    PO22 7NB Bognor Regis
    West Sussex
    United KingdomBritish115409100001
    WICKINS, Anthony John
    Valdoe House
    East Lavant
    PO18 8AW Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Valdoe House
    East Lavant
    PO18 8AW Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritish2541040001
    WICKINS, Michael Anthony
    Hazelwood Lodge
    Hennock
    TQ139PU Bovey Tracey
    Devon
    Amministratore
    Hazelwood Lodge
    Hennock
    TQ139PU Bovey Tracey
    Devon
    EnglandBritish114468860007

    ROWES MOTOR COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 03 ago 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cmh (2007) Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 ago 2009
    Consegnato il 05 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 03 ago 2009
    Consegnato il 05 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 lug 2005
    Consegnato il 27 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Friday Investments Limited
    Transazioni
    • 27 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 lug 2005
    Consegnato il 27 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Silvershine Investments Limited
    Transazioni
    • 27 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 lug 2005
    Consegnato il 27 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anthony and Deidre Wickens and Wolanski & Co Trustees
    Transazioni
    • 27 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 gen 2004
    Consegnato il 10 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Black Horse Limited
    Transazioni
    • 10 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 02 gen 2003
    Consegnato il 10 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 lug 2001
    Consegnato il 12 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust PLC
    Transazioni
    • 12 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 19 ott 1998
    Consegnato il 23 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's stocks of new and used motor vehicles from time to time.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 ago 1998
    Consegnato il 17 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ROWES MOTOR COMPANY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 ott 2013Inizio della liquidazione
    22 ott 2015Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Richard Phillips
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praticante
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Julie Ann Swan
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex
    Praticante
    Pcr (London) Llp St Martins House
    The Runway
    HA4 6SE South Ruislip
    Middlesex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0