EUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED

EUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03521606
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova EUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLOSEDUTY LIMITED04 mar 199804 mar 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di EUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per EUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 09 ago 2012

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Antony Bryan Isaac come amministratore in data 22 lug 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 gen 2012

    Stato del capitale al 09 gen 2012

    • Capitale: GBP 16,001,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    10 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Intercompany debt waived section 175 14/12/2010
    RES13

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Stevens come segretario

    1 pagineTM02

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Andrew John Stevens il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Antony Bryan Isaac il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Anthony David Levy il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di EUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WALL, James Cameron
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Segretario
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    British11724060005
    LEVY, Anthony David
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Amministratore
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    United KingdomBritishChartered Accountant98888430001
    SCHMIDT, Dirk
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Amministratore
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    GermanBanker111394730001
    DAVEY, Anthony Charles
    58 Claremont Road
    N6 5BY London
    Segretario
    58 Claremont Road
    N6 5BY London
    British9757400001
    MOORE, Sandra Ann
    16 The Acorns 95 Augustus Road
    Wimbledon
    SW19 6DQ London
    Segretario
    16 The Acorns 95 Augustus Road
    Wimbledon
    SW19 6DQ London
    Irish/Zimbabwean45088240002
    MORRISON, Audrey
    20 Bliss Avenue
    SG17 5SF Shefford
    Bedfordshire
    Segretario
    20 Bliss Avenue
    SG17 5SF Shefford
    Bedfordshire
    BritishCompany Secretary44972470001
    STEVENS, Andrew John
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Segretario
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    British117838840001
    WILKINSON, James Frederick
    25 The Greenwood
    GU1 2ND Guildford
    Surrey
    Segretario
    25 The Greenwood
    GU1 2ND Guildford
    Surrey
    BritishSolicitor49116870001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AHLGREN, Ross David
    Garden Cottage, Hall Place
    Burchetts Green Road, Burchetts Gree
    SL6 6QP Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Garden Cottage, Hall Place
    Burchetts Green Road, Burchetts Gree
    SL6 6QP Maidenhead
    Berkshire
    AmericanDirector60026800003
    BAIRD, John David Lowis
    67 Onslow Road
    TW10 6QA Richmond
    Surrey
    Amministratore
    67 Onslow Road
    TW10 6QA Richmond
    Surrey
    BritishSales Director13191220001
    COWLEY, Andrew Christian
    21 Sutherland Street
    SW1V 4JU London
    Amministratore
    21 Sutherland Street
    SW1V 4JU London
    United KingdomBritishMerchant Banker71336420002
    DAVEY, Anthony Charles
    58 Claremont Road
    N6 5BY London
    Amministratore
    58 Claremont Road
    N6 5BY London
    United KingdomBritishChartered Accountant9757400001
    DIAZ ASPER, Alex Louis
    2 Swan Lane
    Riverbank House
    EC4R 3UX London
    Amministratore
    2 Swan Lane
    Riverbank House
    EC4R 3UX London
    United States Of AmericaBanker99057900002
    HANFORD, Timothy John
    9 Delvino Road
    SW6 4AE London
    Amministratore
    9 Delvino Road
    SW6 4AE London
    BritishBanker92173090002
    ISAAC, Antony Bryan
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    Amministratore
    30 Gresham Street
    London
    EC2V 7PG
    BritishAccountant121490770001
    LOUKES, Elain Elder, Dr
    69 Hornsey La Gardens
    N6 5PA London
    Amministratore
    69 Hornsey La Gardens
    N6 5PA London
    BritishBanker115474860001
    PETITBON, Maurizio
    3 Draycott Place
    SW3 2SE London
    Amministratore
    3 Draycott Place
    SW3 2SE London
    United KingdomItalianDirector60151970002
    PITCHER, Neil
    37 Hide Road
    HA1 4SG Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    37 Hide Road
    HA1 4SG Harrow
    Middlesex
    BritishDirector67436320001
    STEIN, Raoul
    David Elazar 60
    Raanana
    43205
    Israel
    Amministratore
    David Elazar 60
    Raanana
    43205
    Israel
    IsraeliV C88670900001
    TAYLOR, Richard Mark
    Cetlas Farm Road
    HA6 2NZ Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    Cetlas Farm Road
    HA6 2NZ Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishDirector46764080001
    VADING, Marten Johan Georg
    Valhallavagen 126
    FOREIGN Stockholm
    11441
    Sweden
    Amministratore
    Valhallavagen 126
    FOREIGN Stockholm
    11441
    Sweden
    SwedishVenture Capital79237300001
    WALKER, Jonathan Strachan
    28 Sunset Road
    Darien Connecticut 06820
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    28 Sunset Road
    Darien Connecticut 06820
    FOREIGN Usa
    BritishMerchant Banker60307080003
    WHITE, Andrew John
    White Timbers Ewhurst Green
    Ewhurst
    GU6 7SF Cranleigh
    Surrey
    Amministratore
    White Timbers Ewhurst Green
    Ewhurst
    GU6 7SF Cranleigh
    Surrey
    BritishBanker8107360001
    WILLIAMS, Malcolm Francis
    Gatsworth Marley Lane
    GU27 3PZ Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    Gatsworth Marley Lane
    GU27 3PZ Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritishMerchant Banker11934580002
    WOOLLEY, Geoffrey Tanner
    One Post Office Square
    \3820
    Boston
    Massachusetts 02109
    U S A
    Amministratore
    One Post Office Square
    \3820
    Boston
    Massachusetts 02109
    U S A
    AmericanCompany Director82149390001
    WOOLLEY, Geoffrey
    44 Montgomery Street
    42nd Floor
    94104 San Francisco
    Usa
    Amministratore
    44 Montgomery Street
    42nd Floor
    94104 San Francisco
    Usa
    AmericanDirector60026250001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    WFW LEGAL SERVICES LIMITED
    15 Appold Street
    EC2A 2HB London
    Amministratore
    15 Appold Street
    EC2A 2HB London
    18093320001

    EUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 29 nov 2004
    Consegnato il 04 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £57,000.00 together with value added tax thereon and placed in a specifically designated deposit account together with any sums paid in the account and any interest credited to the account and which has not been released to the company.
    Persone aventi diritto
    • Holborn Links Limited
    Transazioni
    • 04 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 26 nov 2001
    Consegnato il 08 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as original obligee or as assignee or transferee, including (without limitation) any amount owed by the company to the chargee pursuant to a deed of guarantee and indeminty of europe venture partners (holdings) limited's liabilities to the chargee dated of even date with the debenture and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Kleinwort Wasserstein Limited
    Transazioni
    • 08 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment and charge
    Creato il 28 mar 2001
    Consegnato il 10 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the lease agreement or this assignment and charge
    Brevi particolari
    All right,title,benefit and interest in respect of the sub-lease agreement and all claims for damages and other rights and remedies in respect of the sub-lease agreement; all moneys due thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dresdner Kleinwort Benson Finance Limited
    Transazioni
    • 10 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 22 gen 2001
    Consegnato il 26 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £57,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    A deposit of £57,500.
    Persone aventi diritto
    • Holborn Links Limited
    Transazioni
    • 26 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 20 ott 2000
    Consegnato il 01 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee together with all interest payable thereon and all other sums payable under the agreement with respect to any advance or which the chargee has allocated to any advance
    Brevi particolari
    All the right title and interest whatsoever whether present or future proprietary contractual or otherwise under or arising out of in respect of the lease agreement and the kbl participation related to the lease agreement and the icl headlease in respect of the equipment the subject of the lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gatx European Technology Ventures
    Transazioni
    • 01 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 20 ott 2000
    Consegnato il 31 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as defined in the master limited recourse uncommitted loan facility agreement dated 20 october 2000
    Brevi particolari
    By way of assignment the lender's percentage of all the borrowers arising the lease agreement all the rights arising from or in respect of the equipment.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Mezzanine Limited
    Transazioni
    • 31 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Facility agreement
    Creato il 08 ago 2000
    Consegnato il 25 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under any financing document
    Brevi particolari
    Any credit balance to which the borrower is then entitled on any account of the borrower with that finance party. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank (Nederland) N.V., (the "Security Agent")
    Transazioni
    • 25 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of amendment and restatement (relating to a debenture dated 28 september 1999)
    Creato il 08 ago 2000
    Consegnato il 25 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due owing or payable by the company to the chargee or any of the lenders under or in respect of the facility agreement or security documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank (Nederland) N.V., (the "Security Agent")
    Transazioni
    • 25 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 set 1999
    Consegnato il 15 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the lenders (as defined) under or in respect of the facility agreement (as defined) or the debenture and on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meespierson Nv (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 15 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 mag 1999
    Consegnato il 28 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the facility agreement of even date or the debenture on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Mezzanine Limited
    Transazioni
    • 28 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EUROPEAN VENTURE PARTNERS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 ago 2012Inizio della liquidazione
    12 nov 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0