ECD (ONLEY) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ECD (ONLEY) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03524819 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ECD (ONLEY) LIMITED?
- Costruzione di edifici commerciali (41201) / Costruzioni
- Attività di ordine e sicurezza pubblica (84240) / Amministrazione pubblica e difesa; previdenza sociale obbligatoria
Dove si trova ECD (ONLEY) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o SMITH & WILLIAMSON LLP Portwall Place Portwall Lane BS1 6NA Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di ECD (ONLEY) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per ECD (ONLEY) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Chris Burlton il 26 gen 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Third Floor Broad Quay House Prince Street Bristol BS1 4DJ a C/O Smith & Williamson Llp Portwall Place Portwall Lane Bristol BS1 6NA in data 15 giu 2017 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Semperian Secretariat Services Limited il 19 mag 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Campbell Ritchie come amministratore in data 31 mar 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Roger Cook come amministratore in data 18 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gawie Murray Nienaber come amministratore in data 18 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vaishali Jagdish Patel come amministratore in data 18 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Parker come amministratore in data 18 mag 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Roger Cook il 01 lug 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Chris Burlton come amministratore in data 02 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Vaishali Jagdish Patel come amministratore in data 17 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2014 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ECD (ONLEY) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMPERIAN SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | 1 Gresham Street EC2V 7BX London 4th Floor United Kingdom | 107624260005 | |||||||
| BURLTON, Chris | Amministratore | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 191923330001 | |||||
| ANDERSON, David Alexander John | Segretario | 4 Elm Tree Avenue KT10 8JG Esher Surrey | British | 94497310001 | ||||||
| HERZBERG, Francis Robin | Segretario | Connaught Gardens HP4 1SF Berkhamsted 6 Hertfordshire | British | 52429400001 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| ANDERSON, David Alexander John | Amministratore | 4 Elm Tree Avenue KT10 8JG Esher Surrey | British | 94497310001 | ||||||
| BANKS, Andrew David | Amministratore | St. Marys Cowl Lane, Winchcombe GL54 5RA Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 164295230001 | |||||
| BIRCH, Alan Edward | Amministratore | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 90700330001 | |||||
| BIRCH, Alan Edward | Amministratore | 7 Silsbury Grove Standish WN6 0EY Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 90700330001 | |||||
| BROWN, Matthew Charles | Amministratore | Southside 105 Victoria Street SW1E 6QT London G4s England England | England | British | 181465860001 | |||||
| BROWN, Stephen Richard | Amministratore | 8 Arbour Close GL55 6RR Mickleton Gloucestershire | British | 15085940005 | ||||||
| COOK, Paul Roger | Amministratore | 105 Victoria St SW1E 6QT London Southside United Kingdom | Uk | British | 117120110001 | |||||
| DALGLEISH, Bruce Warren | Amministratore | Post Box House Abinger Road RH5 6HD Coldharbour Surrey | United Kingdom | British | 106281140002 | |||||
| DALGLEISH, Bruce Warren | Amministratore | Post Box House Abinger Road RH5 6HD Coldharbour Surrey | United Kingdom | British | 106281140002 | |||||
| ELLIOTT, Christopher | Amministratore | Woodcote House Broad Lane Bishampton WR10 2LY Pershore Worcestershire | England | British | 64082070001 | |||||
| FARLEY, Graham | Amministratore | 9 Manor Close Hinstock TF9 2TZ Market Drayton Salop | United Kingdom | British | 183764380001 | |||||
| GILBEY, Hannah | Amministratore | 14 Dane Park CM23 2PR Bishops Stortford Hertfordshire | British | 78180430001 | ||||||
| GIRLING, Christopher Francis | Amministratore | 12 Spithead Close PO34 5AZ Seaview Isle Of Wight | British | 67125270002 | ||||||
| HARROWER, James Arthur | Amministratore | 24 Lifford Gardens WR12 7DA Broadway Worcestershire | British | 12257110001 | ||||||
| HERZBERG, Francis Robin | Amministratore | Connaught Gardens HP4 1SF Berkhamsted 6 Hertfordshire | England | British | 52429400001 | |||||
| HERZBERG, Francis Robin | Amministratore | Connaught Gardens HP4 1SF Berkhamsted 6 Hertfordshire | England | British | 52429400001 | |||||
| HOLDEN-ROSS, John | Amministratore | Longbourn Smith Lane Mobberley WA16 7QE Knutsford Cheshire | British | 41661700001 | ||||||
| JONES, Stuart Nigel | Amministratore | 23 Old Farm Drive Codsall WV8 1GF Wolverhampton West Midlands | British | 79744320001 | ||||||
| LAVERS, Michael John | Amministratore | 2 Binden Road W12 9RJ London | England | British | 3090450001 | |||||
| MALMBERG, Louis Joannes | Amministratore | Scheveningseslag 87 2586 KW The Hague Netherlands | Dutch | 45086130001 | ||||||
| MCCULLOCH, Paul | Amministratore | 208 Worple Road Wimbledon SW20 8RH London Greater London | British | 116859370001 | ||||||
| MCEWAN, Euan | Amministratore | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | 110597480001 | ||||||
| MORGAN, David Keir Ewart | Amministratore | Care And Justice 5th Floor, Southside 105 Victoria Street SW1E 6QT London G4s England England | England | British | 106484320002 | |||||
| MORRIS, Richard | Amministratore | Old Park Lane M41 7HA Manchester 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 159675380001 | |||||
| NIENABER, Gawie Murray | Amministratore | 105 Victoria St SW1E 6QT London Southside England England | England | British | 187146260001 | |||||
| OSBORNE, Robert Charles | Amministratore | Heath View Bromstead Common TF10 9DG Newport Shropshire | British | 68448420001 | ||||||
| PARKER, John | Amministratore | Chalgrove Field Oakhill MK5 6AJ Milton Keynes Oakhill Stc England England | United Kingdom | English | 182836610001 | |||||
| PATEL, Vaishali Jagdish | Amministratore | 105 Victoria St SW1E 6QT London Southside United Kingdom | United Kingdom | British | 192721880001 | |||||
| RAVI KUMAR, Balasingham | Amministratore | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 138392160001 | |||||
| RAVI KUMAR, Balasingham | Amministratore | Arlington House Bath Street BA1 1QN Bath 30 | United Kingdom | British | 138392160001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per ECD (ONLEY) LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 10 mar 2017 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
ECD (ONLEY) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Creato il 28 ago 2012 Consegnato il 07 set 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H property at rainsbrook secure training centre (formerly k/a onley secure training centre and right title and interest in to and under the operating agreement see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Ywu supplemental fixed charge | Creato il 28 nov 2005 Consegnato il 14 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All property referred to in schedules b, B1 and B2 of an agreement dated 3 july 1998 and other equipment referred to in schedules a, A1 and A2 of the said agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 28 giu 2004 Consegnato il 09 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The property being all that l/h property k/a onley secure training centre, onley, northamptonshire, including all rights from time to time attached or appurtenant thereto and all buildings, and all fixtures belonging to the company from time to time therein or thereon.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental fixed charge | Creato il 09 ago 2001 Consegnato il 28 ago 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the dcmf contract (as defined) | |
Brevi particolari The company's right, title and interest (present and future) to and in the equipment, including all moneys which at any time may be or become payable to the company and the proceeds of any claims, awards and judgements which at any time become receivable or are received by the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge debenture (as defined) | Creato il 03 lug 1998 Consegnato il 13 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with any finance document (as defined) | |
Brevi particolari L/Hold property at the site at onley,northamptonshire; see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge (as defined) | Creato il 03 lug 1998 Consegnato il 13 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with any finance document (as defined) | |
Brevi particolari L/Hold property known as onley secure training centre,onley,northamptonshire with all related rights from time to time and all buildings,fixtures thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of fixed charge | Creato il 03 lug 1998 Consegnato il 09 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The obligation due from the company to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement dated 3RD july 1998 | |
Brevi particolari All the right title and interest (present and future) to and in the equipment (as defined on the front of the form 395 in the "amount secured" box) by way of first fixed charge.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
ECD (ONLEY) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0