LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED
Panoramica
Nome della società | LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03525337 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
- Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
- Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
- Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione
Dove si trova LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 2nd Floor Maxis 2 Western Road RG12 1RT Bracknell Berkshire United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
STARNFLEET LIMITED | 11 mar 1998 | 11 mar 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3 the Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU a 2nd Floor Maxis 2 Western Road Bracknell Berkshire RG12 1RT in data 14 dic 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 27 set 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Nomina di Martin Tanti Felli come amministratore in data 31 dic 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Martin John Oliver come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Hebe Smythe Doneski come amministratore in data 31 dic 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mar 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 100 New Bridge Street London EC4V 6JA a 5th Floor 6 st. Andrew Street London EC4A 3AE | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Abagado Nominees Limited come segretario in data 31 gen 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Nomina di Tmf Corporate Administration Services Limited come segretario in data 31 gen 2017 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Hebe Smythe Doneski il 01 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 20 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 16 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 15 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 18 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONESKI, Hebe Smythe | Segretario | 14400 North 87th Street Scottsdale Az 85260 United States | British | 176516940001 | ||||||||||
TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Segretario | 6 St. Andrew Street EC4A 3AE London 5th Floor United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
FELLI, Martin Tanti | Amministratore | The Arena, Downshire Way Bracknell RG12 1PU Berkshire 3 United Kingdom | United States | American | Lawyer | 246400690001 | ||||||||
MAYNARD, Daniel James | Amministratore | 14400 North 87th Street Scottsdale Az 85260 United States | United States | American | Business Executive | 176510040001 | ||||||||
BOSSON, Paul Francis | Segretario | 7 Seer Mead Seer Green HP9 2QL Beaconsfield Buckinghamshire | British | Director | 82707040001 | |||||||||
BURNS, Glenn Anthony Balfour | Segretario | 8 Claymoor Park Booker SL7 3DL Marlow Buckinghamshire | British | Company Director | 52856690002 | |||||||||
HUDSON, Benjamin Charles | Segretario | Stokenchurch Business Park Ibstone Road Stokenchurch HP14 3AQ High Wycombe Beacon House Buckinghamshire | British | 118067470001 | ||||||||||
PALMER, Richard John | Segretario | 19 Gore Road SL1 8AB Burnham Berkshire | British | 106649880001 | ||||||||||
ABAGADO NOMINEES LIMITED | Segretario | New Bridge Street EC4V 6JA London 100 United Kingdom |
| 176522030001 | ||||||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
BOSSON, Paul Francis | Amministratore | 7 Seer Mead Seer Green HP9 2QL Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | Director | 82707040001 | ||||||||
BUNKHOLDER MEIER, Joy Marie | Amministratore | 20700 Swenson Drive Waukesha Redprairie Corporation Wi 53186 United States | Usa | United States | Business Executive | 169483960001 | ||||||||
BURNETT, Michael Sean, Mr. | Amministratore | 14400 North 87th Street Scottsdale Az 85260 Usa | Usa | American | Business Executive | 176510760001 | ||||||||
BURNS, Glenn Anthony Balfour | Amministratore | 8 Claymoor Park Booker SL7 3DL Marlow Buckinghamshire | Uk | British | Company Director | 52856690002 | ||||||||
CHARLTON, Peter John | Amministratore delegato nominato | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||||||
DAWSON, Fraser James | Amministratore | 55 Wavendon Avenue W4 4NT London | British | Director | 58811180002 | |||||||||
DEAN, Michael John Franks | Amministratore | 39 Selwood Way Downley HP13 5XR High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 67479680001 | ||||||||
DONESKI, Hebe Smythe | Amministratore | 14400 North 87th Street Scottsdale Az 85260 United States | United States | American | Business Executive | 176511590002 | ||||||||
FESE, Laura Lynn | Amministratore | 20700 Swenson Drive Waukesha Redprairie Corporation Wi 53186 United States | Usa | American | Attorney | 95896940009 | ||||||||
GETTO, Steven | Amministratore | 2895 Parkside Drive Highland Park Il 60035 America | American | Accountant | 108969270001 | |||||||||
HISCOX, Martin | Amministratore | Stokenchurch Business Park Ibstone Road Stokenchurch HP14 3AQ High Wycombe Beacon House Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 35292070001 | ||||||||
JAZWIEC, John Gerard | Amministratore | 282 Claremont Street Elmhurst Illinois 60126 Usa | Usa | Executive | 82112030001 | |||||||||
MEDLOCK, Charles Richard Kenneth | Amministratore | 1 Blackwater View Lower Sandhurst Road Finchampstead RG40 3TF Wokingham Berkshire | British | Company Director | 23450040004 | |||||||||
NEVILLE, Gerald Worley | Amministratore | 738 Portpatrick Place Fort Mill S C 29708 Usa | American | Company Director | 59397460003 | |||||||||
OLIVER, Martin John | Amministratore | Ibstone Road Stokenchurch HP14 3AQ High Wycombe Beacon House Stokenchurch Business Park Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Business Executive | 92689010002 | ||||||||
RICHARDS, Martin Edgar | Amministratore delegato nominato | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||||||
SHEPHERD, Ian Philip | Amministratore | Bigmore Farm Bigmore Lane HP14 3UP Stokenchurch Buckinghamshire | England | British | Company Director | 111287320001 | ||||||||
WILLIAMS, Raymond Martin | Amministratore | 45 Creslow Way HP17 8YN Stone Buckinghamshire | England | British | Development Director | 58811550002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redprairie Acquisition Company Limited | 06 apr 2016 | The Arena, Downshire Way Bracknell RG12 1PU Berkshire 3 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Charge over cash deposit | Creato il 12 feb 2004 Consegnato il 17 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The deposit being the cash deposit in the name of the company held in account number 20943001, sort code 12-09-49 and all the present and future rights, titles and benefits of the company in the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over cash deposit | Creato il 29 set 2003 Consegnato il 11 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The deposit and all the present and future rights titles and benefits of the company in the deposit (but subject to redemption on payment of all moneys and the discharge of the secured liabilities covenanted to be paid or discharged under the deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Pledge over shares | Creato il 14 ago 2003 Consegnato il 04 set 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The share account opened in the share ledger books of logistics and internet system sas with £5,000 shares and all dividends interest and distributions received or to be received by it in respect of its interest. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 ago 2001 Consegnato il 15 ago 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All or any monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee acting on its own behalf and as trustee for the lender on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 giu 1998 Consegnato il 23 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0