LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED

LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03525337
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
    • Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor Maxis 2
    Western Road
    RG12 1RT Bracknell
    Berkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STARNFLEET LIMITED11 mar 199811 mar 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 the Arena Downshire Way Bracknell Berkshire RG12 1PU a 2nd Floor Maxis 2 Western Road Bracknell Berkshire RG12 1RT in data 14 dic 2018

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 27 set 2018

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of the share premium account 27/09/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Martin Tanti Felli come amministratore in data 31 dic 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Martin John Oliver come amministratore in data 31 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hebe Smythe Doneski come amministratore in data 31 dic 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mar 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 100 New Bridge Street London EC4V 6JA a 5th Floor 6 st. Andrew Street London EC4A 3AE

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Abagado Nominees Limited come segretario in data 31 gen 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Tmf Corporate Administration Services Limited come segretario in data 31 gen 2017

    2 pagineAP04

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Hebe Smythe Doneski il 01 gen 2017

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    20 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 apr 2016

    Stato del capitale al 13 apr 2016

    • Capitale: GBP 4,515,077.77
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 apr 2015

    Stato del capitale al 29 apr 2015

    • Capitale: GBP 4,515,077.77
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DONESKI, Hebe Smythe
    14400 North 87th Street
    Scottsdale
    Az 85260
    United States
    Segretario
    14400 North 87th Street
    Scottsdale
    Az 85260
    United States
    British176516940001
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Segretario
    6 St. Andrew Street
    EC4A 3AE London
    5th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    FELLI, Martin Tanti
    The Arena, Downshire Way
    Bracknell
    RG12 1PU Berkshire
    3
    United Kingdom
    Amministratore
    The Arena, Downshire Way
    Bracknell
    RG12 1PU Berkshire
    3
    United Kingdom
    United StatesAmericanLawyer246400690001
    MAYNARD, Daniel James
    14400 North 87th Street
    Scottsdale
    Az 85260
    United States
    Amministratore
    14400 North 87th Street
    Scottsdale
    Az 85260
    United States
    United StatesAmericanBusiness Executive176510040001
    BOSSON, Paul Francis
    7 Seer Mead
    Seer Green
    HP9 2QL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    7 Seer Mead
    Seer Green
    HP9 2QL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector82707040001
    BURNS, Glenn Anthony Balfour
    8 Claymoor Park
    Booker
    SL7 3DL Marlow
    Buckinghamshire
    Segretario
    8 Claymoor Park
    Booker
    SL7 3DL Marlow
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director52856690002
    HUDSON, Benjamin Charles
    Stokenchurch Business Park Ibstone Road
    Stokenchurch
    HP14 3AQ High Wycombe
    Beacon House
    Buckinghamshire
    Segretario
    Stokenchurch Business Park Ibstone Road
    Stokenchurch
    HP14 3AQ High Wycombe
    Beacon House
    Buckinghamshire
    British118067470001
    PALMER, Richard John
    19 Gore Road
    SL1 8AB Burnham
    Berkshire
    Segretario
    19 Gore Road
    SL1 8AB Burnham
    Berkshire
    British106649880001
    ABAGADO NOMINEES LIMITED
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Segretario
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1688036
    176522030001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BOSSON, Paul Francis
    7 Seer Mead
    Seer Green
    HP9 2QL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    7 Seer Mead
    Seer Green
    HP9 2QL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector82707040001
    BUNKHOLDER MEIER, Joy Marie
    20700 Swenson Drive
    Waukesha
    Redprairie Corporation
    Wi 53186
    United States
    Amministratore
    20700 Swenson Drive
    Waukesha
    Redprairie Corporation
    Wi 53186
    United States
    UsaUnited StatesBusiness Executive169483960001
    BURNETT, Michael Sean, Mr.
    14400 North 87th Street
    Scottsdale
    Az 85260
    Usa
    Amministratore
    14400 North 87th Street
    Scottsdale
    Az 85260
    Usa
    UsaAmericanBusiness Executive176510760001
    BURNS, Glenn Anthony Balfour
    8 Claymoor Park
    Booker
    SL7 3DL Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 Claymoor Park
    Booker
    SL7 3DL Marlow
    Buckinghamshire
    UkBritishCompany Director52856690002
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    DAWSON, Fraser James
    55 Wavendon Avenue
    W4 4NT London
    Amministratore
    55 Wavendon Avenue
    W4 4NT London
    BritishDirector58811180002
    DEAN, Michael John Franks
    39 Selwood Way
    Downley
    HP13 5XR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    39 Selwood Way
    Downley
    HP13 5XR High Wycombe
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector67479680001
    DONESKI, Hebe Smythe
    14400 North 87th Street
    Scottsdale
    Az 85260
    United States
    Amministratore
    14400 North 87th Street
    Scottsdale
    Az 85260
    United States
    United StatesAmericanBusiness Executive176511590002
    FESE, Laura Lynn
    20700 Swenson Drive
    Waukesha
    Redprairie Corporation
    Wi 53186
    United States
    Amministratore
    20700 Swenson Drive
    Waukesha
    Redprairie Corporation
    Wi 53186
    United States
    UsaAmericanAttorney95896940009
    GETTO, Steven
    2895 Parkside Drive
    Highland Park
    Il 60035
    America
    Amministratore
    2895 Parkside Drive
    Highland Park
    Il 60035
    America
    AmericanAccountant108969270001
    HISCOX, Martin
    Stokenchurch Business Park
    Ibstone Road Stokenchurch
    HP14 3AQ High Wycombe
    Beacon House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Stokenchurch Business Park
    Ibstone Road Stokenchurch
    HP14 3AQ High Wycombe
    Beacon House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director35292070001
    JAZWIEC, John Gerard
    282 Claremont Street
    Elmhurst
    Illinois 60126
    Usa
    Amministratore
    282 Claremont Street
    Elmhurst
    Illinois 60126
    Usa
    UsaExecutive82112030001
    MEDLOCK, Charles Richard Kenneth
    1 Blackwater View
    Lower Sandhurst Road Finchampstead
    RG40 3TF Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    1 Blackwater View
    Lower Sandhurst Road Finchampstead
    RG40 3TF Wokingham
    Berkshire
    BritishCompany Director23450040004
    NEVILLE, Gerald Worley
    738 Portpatrick Place
    Fort Mill
    S C 29708
    Usa
    Amministratore
    738 Portpatrick Place
    Fort Mill
    S C 29708
    Usa
    AmericanCompany Director59397460003
    OLIVER, Martin John
    Ibstone Road
    Stokenchurch
    HP14 3AQ High Wycombe
    Beacon House Stokenchurch Business Park
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ibstone Road
    Stokenchurch
    HP14 3AQ High Wycombe
    Beacon House Stokenchurch Business Park
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishBusiness Executive92689010002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SHEPHERD, Ian Philip
    Bigmore Farm
    Bigmore Lane
    HP14 3UP Stokenchurch
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Bigmore Farm
    Bigmore Lane
    HP14 3UP Stokenchurch
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director111287320001
    WILLIAMS, Raymond Martin
    45 Creslow Way
    HP17 8YN Stone
    Buckinghamshire
    Amministratore
    45 Creslow Way
    HP17 8YN Stone
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDevelopment Director58811550002

    Chi sono le persone con controllo significativo di LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Arena, Downshire Way
    Bracknell
    RG12 1PU Berkshire
    3
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Arena, Downshire Way
    Bracknell
    RG12 1PU Berkshire
    3
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04967011
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LOGISTICS TECHNOLOGY GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over cash deposit
    Creato il 12 feb 2004
    Consegnato il 17 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit being the cash deposit in the name of the company held in account number 20943001, sort code 12-09-49 and all the present and future rights, titles and benefits of the company in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over cash deposit
    Creato il 29 set 2003
    Consegnato il 11 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit and all the present and future rights titles and benefits of the company in the deposit (but subject to redemption on payment of all moneys and the discharge of the secured liabilities covenanted to be paid or discharged under the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge over shares
    Creato il 14 ago 2003
    Consegnato il 04 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The share account opened in the share ledger books of logistics and internet system sas with £5,000 shares and all dividends interest and distributions received or to be received by it in respect of its interest.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 ago 2001
    Consegnato il 15 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All or any monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee acting on its own behalf and as trustee for the lender on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Indigo Capital Limited
    Transazioni
    • 15 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 giu 1998
    Consegnato il 23 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0