THE RUTLAND ARMS HOTEL (1998) LIMITED

THE RUTLAND ARMS HOTEL (1998) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE RUTLAND ARMS HOTEL (1998) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03525871
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE RUTLAND ARMS HOTEL (1998) LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova THE RUTLAND ARMS HOTEL (1998) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5th Floor 83-85 Baker Street
    W1U 6AG London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE RUTLAND ARMS HOTEL (1998) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per THE RUTLAND ARMS HOTEL (1998) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Indirizzo della sede legale modificato da 106 Leadenhall Street London EC3A 4AA England a 5th Floor 83-85 Baker Street London W1U 6AG in data 01 set 2021

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Sharon Michelle Badelek come amministratore in data 12 ago 2021

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Friars House Quaker Lane Boston Lincolnshire PE21 6BZ England a 106 Leadenhall Street London EC3A 4AA in data 31 ago 2021

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Rooney Anand come amministratore in data 12 ago 2021

    2 pagineAP01

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Memorandum e Statuto

    37 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Hazel Joyce Renshaw come segretario in data 11 feb 2020

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Hazel Joyce Renshaw come amministratore in data 11 feb 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Christopher John Renshaw come amministratore in data 11 feb 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Edward Walsh come amministratore in data 11 feb 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Kevin Charity come amministratore in data 11 feb 2020

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 mar 2020 al 31 mar 2020

    1 pagineAA01

    Notifica di The Coaching Inn Group Ltd come persona con controllo significativo il 11 feb 2020

    2 paginePSC02

    Indirizzo della sede legale modificato da Rutland Arms Hotel the Square Bakewell Derbyshire DE45 1BT a Friars House Quaker Lane Boston Lincolnshire PE21 6BZ in data 12 feb 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione di Renco (Chesterfield) Limited come persona con controllo significativo il 11 feb 2020

    1 paginePSC07

    Cessazione di Hazel Joyce Renshaw come persona con controllo significativo il 11 feb 2020

    1 paginePSC07

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 mar 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 mar 2018

    8 pagineAA

    Notifica di Renco (Chesterfield) Limited come persona con controllo significativo il 20 mar 2018

    2 paginePSC02

    Chi sono gli amministratori di THE RUTLAND ARMS HOTEL (1998) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANAND, Rooney
    83-85 Baker Street
    W1U 6AG London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    83-85 Baker Street
    W1U 6AG London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish77808680003
    BADELEK, Sharon Michelle
    83-85 Baker Street
    W1U 6AG London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    83-85 Baker Street
    W1U 6AG London
    5th Floor
    England
    EnglandBritish277784190001
    CHARITY, Kevin
    83-85 Baker Street
    W1U 6AG London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    83-85 Baker Street
    W1U 6AG London
    5th Floor
    England
    EnglandEnglish62498480002
    WALSH, Edward
    83-85 Baker Street
    W1U 6AG London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    83-85 Baker Street
    W1U 6AG London
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish267112610001
    DONEGAN, Sarah
    Ryton Dale
    Bawtry Road
    S81 8HG Blyth
    Nottinghamshire
    Segretario
    Ryton Dale
    Bawtry Road
    S81 8HG Blyth
    Nottinghamshire
    British21811090002
    FEATHER, Peter
    12 Boundary Way
    DL10 5QF Richmond
    North Yorkshire
    Segretario
    12 Boundary Way
    DL10 5QF Richmond
    North Yorkshire
    British57686220002
    RENSHAW, Hazel Joyce
    Quaker Lane
    PE21 6BZ Boston
    Friars House
    Lincolnshire
    England
    Segretario
    Quaker Lane
    PE21 6BZ Boston
    Friars House
    Lincolnshire
    England
    158817080001
    BRISTOL LEGAL SERVICES LIMITED
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Avon
    Segretario nominato
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Avon
    900001040001
    DONEGAN, David
    Ryton Dale
    Bawtry Road Blyth
    S81 8HG Worksop
    North Nottinghamshire
    Amministratore
    Ryton Dale
    Bawtry Road Blyth
    S81 8HG Worksop
    North Nottinghamshire
    United KingdomBritish57686040001
    FEATHER, Peter
    12 Boundary Way
    DL10 5QF Richmond
    North Yorkshire
    Amministratore
    12 Boundary Way
    DL10 5QF Richmond
    North Yorkshire
    British57686220002
    RENSHAW, Christopher John
    Quaker Lane
    PE21 6BZ Boston
    Friars House
    Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Quaker Lane
    PE21 6BZ Boston
    Friars House
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritish32182250004
    RENSHAW, Hazel Joyce
    Quaker Lane
    PE21 6BZ Boston
    Friars House
    Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Quaker Lane
    PE21 6BZ Boston
    Friars House
    Lincolnshire
    England
    EnglandBritish53435250004
    BOURSE NOMINEES LIMITED
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Amministratore delegato nominato
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    900016940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE RUTLAND ARMS HOTEL (1998) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Quaker Lane
    PE21 6BZ Boston
    Friars House
    Lincolnshire
    England
    11 feb 2020
    Quaker Lane
    PE21 6BZ Boston
    Friars House
    Lincolnshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleThe Law Of England And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03202237
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    The Square
    DE45 1BT Bakewell
    The Rutland Arms Hotel
    Derbyshire
    England
    20 mar 2018
    The Square
    DE45 1BT Bakewell
    The Rutland Arms Hotel
    Derbyshire
    England
    Forma giuridicaCompany
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02190003
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mrs Hazel Joyce Renshaw
    The Square
    DE45 1BT Bakewell
    Rutland Arms Hotel
    Derbyshire
    01 mar 2017
    The Square
    DE45 1BT Bakewell
    Rutland Arms Hotel
    Derbyshire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    THE RUTLAND ARMS HOTEL (1998) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal and general charge
    Creato il 19 ott 2006
    Consegnato il 25 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Granby works, 4 buxton road, bakewell by way of fixed charge all uncalled capital, intellectual property rights, beneficial interest in all and any stocks, shares and other securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 25 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal and general charge
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 06 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The rutland arms hotel the square bakewell t/no DY294320 by way of fixed charge all the uncalled capital any legal or beneficial interest which the company has in all and any stocks shares and other securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National PLC
    Transazioni
    • 06 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of variation of mortgage ("the deed") supplemental to a mortage dated 1ST march 1999
    Creato il 26 mag 2000
    Consegnato il 02 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Rutland arms hotel the square bakewell derbyshire t/n dy 294320 together with all buildings thereon assigns the goodwill of the business, the benefit of the licences and the benefits respectively carried on or arising in respect of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 02 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 01 mar 1999
    Consegnato il 18 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h rutland arms hotel the square bakewell t/n-DY294320, and assigns the goodwill of the business and the benefit of the licences. By way of floating charge the undertaking and all its other property and assets both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 giu 1998
    Consegnato il 18 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property k/a the rutland arms hotel the square bakewell derbyshire t/n DY294320. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 giu 1998
    Consegnato il 16 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0