SITESCOPE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSITESCOPE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03527086
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SITESCOPE LIMITED?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova SITESCOPE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton
    EX2 7HY Exeter
    Devon
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SITESCOPE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CATALYTIC DATA LIMITED13 mar 199813 mar 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di SITESCOPE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SITESCOPE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SITESCOPE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Mark Francis Milner come amministratore in data 11 gen 2016

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 19/11/2015
    RES13

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03

    Cessazione della carica di Paul Sykes come amministratore in data 30 set 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2015

    Stato del capitale al 31 mar 2015

    • Capitale: GBP 283,875
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    16 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2013 al 31 mar 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 feb 2014

    Stato del capitale al 19 feb 2014

    • Capitale: GBP 283,875
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Stephen Stout come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Francis Milner come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SITESCOPE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CALLCOTT, David William
    2 Northcote Road
    Clifton
    BS8 3HB Bristol
    Segretario
    2 Northcote Road
    Clifton
    BS8 3HB Bristol
    BritishFinance Director85543390001
    CALLCOTT, David William
    2 Northcote Road
    Clifton
    BS8 3HB Bristol
    Amministratore
    2 Northcote Road
    Clifton
    BS8 3HB Bristol
    EnglandBritishDirector85543390001
    DOYLE, Brendan
    152 Crosslet Vale
    Blackheath Road
    SE10 8DL London
    Segretario
    152 Crosslet Vale
    Blackheath Road
    SE10 8DL London
    IrishBusiness Development Director101599710001
    GILLON, Anthony Sean
    The Spiney
    19 Woodlands Road
    BR1 2AD Bromley
    Kent
    Segretario
    The Spiney
    19 Woodlands Road
    BR1 2AD Bromley
    Kent
    EireChartered Accountant115505270001
    ENERGIZE SECRETARY LIMITED
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    Segretario nominato
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    900012910001
    DOYLE, Brendan
    152 Crosslet Vale
    Blackheath Road
    SE10 8DL London
    Amministratore
    152 Crosslet Vale
    Blackheath Road
    SE10 8DL London
    IrishBusiness Development Director101599710001
    EASTERBROOK, Hugh Laurence
    Flat 2
    9 Heath Drive
    NW3 7SN London
    Amministratore
    Flat 2
    9 Heath Drive
    NW3 7SN London
    EnglandBritishManager76586520003
    FRANCIS, Nicholas Roose
    8 Saint Michaels Close
    BR1 2DX Bickley
    Kent
    Amministratore
    8 Saint Michaels Close
    BR1 2DX Bickley
    Kent
    BritishSurveyor74497070001
    GILLON, Anthony Sean
    The Spiney
    19 Woodlands Road
    BR1 2AD Bromley
    Kent
    Amministratore
    The Spiney
    19 Woodlands Road
    BR1 2AD Bromley
    Kent
    United KingdomEireChartered Accountant115505270001
    LAVELLE, Anthony Michael
    118 Murray Avenue
    BR1 3DT Bromley
    Kent
    Amministratore
    118 Murray Avenue
    BR1 3DT Bromley
    Kent
    BritishCompany Director4018040001
    MILNER, Mark Francis
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton
    EX2 7HY Exeter
    Devon
    Amministratore
    7 Abbey Court
    Eagle Way Sowton
    EX2 7HY Exeter
    Devon
    EnglandBritishDirector174048810001
    RE'EM, Daniel
    77c Roupell Street
    SE1 8SS London
    Amministratore
    77c Roupell Street
    SE1 8SS London
    BritishDirector5388110001
    STOUT, Stephen John
    Priors
    Priorsfield Road
    GU7 2RG Hurtmore
    Surrey
    Amministratore
    Priors
    Priorsfield Road
    GU7 2RG Hurtmore
    Surrey
    United KingdomBritishDirector154424780001
    SYKES, Paul
    16 Hidden Meadow Lane
    New Canaan
    Ct 06840
    Usa
    Amministratore
    16 Hidden Meadow Lane
    New Canaan
    Ct 06840
    Usa
    United StatesBritishFinance Director53535790003
    ENERGIZE DIRECTOR LIMITED
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    Amministratore delegato nominato
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    900014010001

    SITESCOPE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 27 dic 2002
    Consegnato il 27 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Õhsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 27 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 28 nov 2001
    Consegnato il 28 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things or any part thereof being 13 PD1816FSRKM 1800MM x 1600MM desk (rh) + acc (cable risers & carrier) 2002-2014 14 PD1816FSLKM 1800MM x 1600MM desk (lh) + ass (cable risers & carrier) 2015-2028 27 PP65MKM 3 drawer mobile pedestal 2029-2055 for further details of the property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 28 nov 2001
    Consegnato il 28 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things or any part thereof being 1 base PV705 240GB filer s/no 513346 1 8100 pc + 1024MB rdram+80GB drive s/no 9NDY60J 1 8100 pc 7NDY60J for further details of the property charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 26 set 2001
    Consegnato il 02 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 26TH september 2001 between the company (as tenant) and the chargee (as landlord)
    Brevi particolari
    All the company right title and interest in and to the deposit of £23,500 and any amounts standing to the credit of the account in which the deposit is placed.
    Persone aventi diritto
    • Lincoln Assurance Limited
    Transazioni
    • 02 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0