ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED

ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03528049
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?

    • Altre attività di servizi di informazione n.c.a. (63990) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Broadgate
    EC2M 2QS London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di John Roger Haworth come amministratore in data 14 apr 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Giles Harvey Roberts Richardson come amministratore in data 16 giu 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Keir Murray Fawcus come amministratore in data 27 gen 2017

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di un amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Low come amministratore in data 30 apr 2017

    2 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mar 2016

    Stato del capitale al 21 mar 2016

    • Capitale: GBP 16,513.3
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2015

    Stato del capitale al 08 mag 2015

    • Capitale: GBP 16,513.3
    SH01

    Cessazione della carica di Stephen Lacey come amministratore in data 06 giu 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephen Lacey come segretario in data 06 giu 2014

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr John Roger Haworth come amministratore in data 12 gen 2015

    3 pagineAP01

    Nomina di Wpp Group (Nominees) Limited come segretario in data 12 gen 2015

    3 pagineAP04

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2014 al 31 dic 2014

    3 pagineAA01

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Bilancio annuale redatto al 16 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 mag 2014

    Stato del capitale al 07 mag 2014

    • Capitale: GBP 16,513.3
    SH01

    Chi sono gli amministratori di ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Segretario
    Farm Street
    W1J 5RJ London
    27
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2757919
    80143770001
    RICHARDSON, Giles Harvey Roberts
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    EnglandBritish224284590001
    GULLIVER, John Keith
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Segretario
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    British147777590001
    LACEY, Stephen
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Segretario
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    167695820001
    LOW, Peter
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Segretario
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    148710950001
    MELVILLE, George Alexander Easson
    77 Brampton Road
    AL1 4QA St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    77 Brampton Road
    AL1 4QA St. Albans
    Hertfordshire
    British70332790001
    STANNETT, Robert William
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    Segretario
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    British141063520001
    WAIT, Sarah Catherine
    2 Brackendale
    Gloucester Road
    KT1 3RL Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    2 Brackendale
    Gloucester Road
    KT1 3RL Kingston Upon Thames
    Surrey
    British34628940002
    WEBBER, Linda
    123 Ellerton Road
    KT6 7UA Surbiton
    Surrey
    Segretario
    123 Ellerton Road
    KT6 7UA Surbiton
    Surrey
    British76795590003
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Segretario nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    BEYTS, Timothy Charles
    92 Louisville Road
    SW17 8RU London
    Amministratore
    92 Louisville Road
    SW17 8RU London
    British11765410002
    FAWCUS, Keir Murray
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish84594470003
    GULLIVER, John Keith
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    Amministratore
    The Registry
    Royal Mint Court
    EC3N 4QN London
    United KingdomBritish147777590001
    HALL, David John
    4 Portobello Studios
    5 Haydens Place
    W11 1LY London
    Amministratore
    4 Portobello Studios
    5 Haydens Place
    W11 1LY London
    EnglandBritish97017290003
    HARKNESS, Peter Martin
    19 Horsley Court
    Montaigne Close Regency Street
    SW1 4BF London
    Amministratore
    19 Horsley Court
    Montaigne Close Regency Street
    SW1 4BF London
    United KingdomBritish146757430001
    HAWORTH, John Roger
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    EnglandBritish91354480002
    HOOPER, John Hamilton
    Silvertrees Wilderness Road
    BR7 5EY Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Silvertrees Wilderness Road
    BR7 5EY Chislehurst
    Kent
    British52456790002
    LACEY, Stephen
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish88368490002
    LOW, Peter
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    Amministratore
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    EnglandBritish65476890002
    OWEN, Michael William Anthony
    Burg Stavenow
    Stavenow
    FOREIGN Germany
    19357
    Amministratore
    Burg Stavenow
    Stavenow
    FOREIGN Germany
    19357
    British71933480004
    SILLETT, Andrew
    2 Brackendale
    Gloucester Road
    KT1 3RL Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    2 Brackendale
    Gloucester Road
    KT1 3RL Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish50213480002
    SOOKE, Thomas Peter
    4 Monmouth Road
    W2 5SB London
    Amministratore
    4 Monmouth Road
    W2 5SB London
    British19451990001
    STANNETT, Robert William
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    Amministratore
    Shalford
    GU4 8JN Guildford
    Northfield
    Surrey
    EnglandBritish141063520001
    TIMSON, Evelyn Ruth
    Garden Hill
    Guildford Road, Westcott
    RH4 3NJ Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Garden Hill
    Guildford Road, Westcott
    RH4 3NJ Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish115799140002
    WAIT, Sarah Catherine
    2 Brackendale
    Gloucester Road
    KT1 3RL Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    2 Brackendale
    Gloucester Road
    KT1 3RL Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish34628940002
    WEBBER, Linda
    123 Ellerton Road
    KT6 7UA Surbiton
    Surrey
    Amministratore
    123 Ellerton Road
    KT6 7UA Surbiton
    Surrey
    EnglandBritish76795590003
    WILSON, Robert
    8 Bywater Road
    South Woodham Ferrers
    CM3 7AJ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    8 Bywater Road
    South Woodham Ferrers
    CM3 7AJ Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish81972040001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Amministratore delegato nominato
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Precise Media Group Holdings Limited
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    01 mar 2017
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    1
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Register
    Numero di registrazione100001
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    ADVANCE MEDIA INFORMATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Accession deed
    Creato il 14 dic 2007
    Consegnato il 21 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property all licences all computers vehicles office equipment and other equipment the benefit of all contracts licences and warranties the charged securities the cash collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 21 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 23 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £135,000 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all the property and undertaking of the company.
    Persone aventi diritto
    • Chrysalis Vct PLC
    Transazioni
    • 23 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 apr 2004
    Consegnato il 08 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 gen 2002
    Consegnato il 06 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee up to £269,000
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Downing Classic Vct 2 PLC, Downing Classic Vct 3 PLC, I-Net Vct PLC, J Hooper,T Sooke, D Hall Lwebber S Wait T Bayts
    Transazioni
    • 06 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0