MITIE ENGINEERING SERVICES (RETAIL) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MITIE ENGINEERING SERVICES (RETAIL) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03532169 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MITIE ENGINEERING SERVICES (RETAIL) LIMITED?
- Installazione elettrica (43210) / Costruzioni
- Installazione idraulica, termica e di climatizzazione (43220) / Costruzioni
Dove si trova MITIE ENGINEERING SERVICES (RETAIL) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MITIE ENGINEERING SERVICES (RETAIL) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| AGENCYEVE LIMITED | 20 mar 1998 | 20 mar 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MITIE ENGINEERING SERVICES (RETAIL) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per MITIE ENGINEERING SERVICES (RETAIL) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 13 gen 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Suzanne Claire Baxter come amministratore in data 26 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ruby Mcgregor-Smith come amministratore in data 26 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ruby Mcgregor-Smith il 25 apr 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per William Robson il 25 apr 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Suzanne Claire Baxter il 25 apr 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mitie Company Secretarial Services Limited il 20 gen 2014 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 8 Monarch Court the Brooms Emersons Green Bristol BS16 7FH* in data 20 gen 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2013 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Nomina di Ruby Mcgregor-Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Suzanne Claire Baxter come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MITIE ENGINEERING SERVICES (RETAIL) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | 114537130001 | |||||||
| RIDLEY, Justin | Amministratore | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 167796840001 | |||||
| ROBSON, William | Amministratore | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | Scotland | British | 282530002 | |||||
| ROSS, Corina Katherine | Segretario | Ainslie's Cottage 30b Belvedere, Lansdown BA1 5HR Bath Avon | British | 69836440002 | ||||||
| THOMAS, Marshall Owen | Segretario | Rushmoor Clevedon Lane BS20 7RH Clapton In Gordano Bristol | British | 90914410001 | ||||||
| WATERS, Anthony Floyd | Segretario | The Stable Block Barley Wood BS40 5SA Wrington Bristol | British | 940440002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ACHESON, Colin Stewart | Amministratore | 191 Sycamore Road GU14 6RQ Farnborough Hampshire | England | British | 48231890002 | |||||
| BAXTER, Suzanne Claire | Amministratore | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 113058450002 | |||||
| BAXTER, Suzanne Claire | Amministratore | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 113058450002 | |||||
| CULLEN, John Derek | Amministratore | 2 Bowenhurst Gardens Church Crookham GU13 0NB Fleet Hampshire | British | 58840190001 | ||||||
| DAVIES, John Stephen | Amministratore | 6 Compass Field RG27 9SH Hook Hampshire | British | 58840150002 | ||||||
| GINGELL, Terry Reginald | Amministratore | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | England | British | 122134750001 | |||||
| GUDGEON, Edward Gerard | Amministratore | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 70395340001 | |||||
| HARPER, David | Amministratore | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 58840170004 | |||||
| HOLTON, Matthew Thomas | Amministratore | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | British | 108793560001 | ||||||
| MCGREGOR-SMITH, Ruby | Amministratore | Harlequin Office Park, Fieldfare Emersons Green BS16 7FN Bristol 1 England England | United Kingdom | British | 39857280005 | |||||
| MCGREGOR-SMITH, Ruby | Amministratore | 8 Monarch Court The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol | United Kingdom | British | 39857280003 | |||||
| OSBORNE, Raymond Thomas | Amministratore | 28 Raleigh Close ME5 7SB Chatham Kent | United Kingdom | British | 81964490002 | |||||
| REED, Martin Frank | Amministratore | The Haven 5 High Way BH18 9NB Broadstone Dorset | British | 58840160002 | ||||||
| STEWART, Ian Reginald | Amministratore | Lullingworth Stroud Road GL6 6UT Painswick Gloucestershire | England | British | 1517500002 | |||||
| TELLING, David Malcolm | Amministratore | Meeting House Farm Long Lane Wrington BS40 5SP Bristol | British | 15023940001 | ||||||
| THOMAS, Marshall Owen | Amministratore | Rushmoor Clevedon Lane BS20 7RH Clapton In Gordano Bristol | British | 90914410001 | ||||||
| THORNTON, Rachel Elizabeth | Amministratore | Sherwood House Station Road, Sandford BS25 5RA Winscombe North Somerset | United Kingdom | British | 4355740001 | |||||
| TIVEY, Michael Anthony | Amministratore | Monarch Court, The Brooms Emersons Green BS16 7FH Bristol 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 37917060003 | |||||
| TRENTHAM, Martin | Amministratore | 90 Whittingham Road B63 3TP Halesowen West Midlands | British | 69756680001 | ||||||
| WILLIAMS, Colin Jeffrey | Amministratore | 64 Berkeley Road Westbury Park BS6 7PL Bristol Avon | England | British | 58581220001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
MITIE ENGINEERING SERVICES (RETAIL) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of rental deposit | Creato il 12 lug 2000 Consegnato il 22 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The initial deposit of £2,250.00 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the deed | |
Brevi particolari The deposit account with lloyds tsb bank PLC as specified in the deed of rent deposit. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0