TELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED

TELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03532626
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    E2 Sussex Manor Business Park
    Gatwick Road
    RH10 9NH Crawley
    Sussex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    URGENTAUTO LIMITED23 mar 199823 mar 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di TELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mar 2015

    Stato del capitale al 27 mar 2015

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 apr 2014

    Stato del capitale al 01 apr 2014

    • Capitale: GBP 3
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2013

    7 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2011

    6 pagineAA

    Nomina di Nicholas Conn come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Martin come amministratore

    1 pagineTM01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 23 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Paul Martin il 23 mar 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Nicholas Simon Conn il 23 mar 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per John Leslie Christmas il 23 mar 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2008

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2007

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di TELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CONN, Nicholas Simon
    Sussex Manor Business Park
    Gatwick Road
    RH10 9NH Crawley
    E2
    Sussex
    Segretario
    Sussex Manor Business Park
    Gatwick Road
    RH10 9NH Crawley
    E2
    Sussex
    British13110780003
    CHRISTMAS, John Leslie
    Sussex Manor Business Park
    Gatwick Road
    RH10 9NH Crawley
    E2
    Sussex
    Amministratore
    Sussex Manor Business Park
    Gatwick Road
    RH10 9NH Crawley
    E2
    Sussex
    EnglandEnglish15610000001
    CONN, Nicholas Simon
    Sussex Manor Business Park
    Gatwick Road
    RH10 9NH Crawley
    E2
    Sussex
    Amministratore
    Sussex Manor Business Park
    Gatwick Road
    RH10 9NH Crawley
    E2
    Sussex
    United KingdomBritish13110780003
    COOK, Russell John
    26 Egmont Road
    KT6 7AT Surbiton
    Surrey
    Segretario
    26 Egmont Road
    KT6 7AT Surbiton
    Surrey
    British64676640001
    DAVIES, Digby John
    1a Cambridge Road
    TW1 2HN Twickenham
    Middlesex
    Segretario
    1a Cambridge Road
    TW1 2HN Twickenham
    Middlesex
    British38937270002
    DAY, Christopher Alexander Coryton
    48 Whitley Court Road
    Quinton
    B32 1EY Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    48 Whitley Court Road
    Quinton
    B32 1EY Birmingham
    West Midlands
    British92047820001
    EVANS, Nerys Helen
    5 St Philips Way
    Islington
    N1 7AJ London
    Segretario
    5 St Philips Way
    Islington
    N1 7AJ London
    British66070850003
    GORDON, Neil Arthur
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    Segretario
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    British73989530001
    MAKANJI, Ashok
    5 Wheatley Drive
    WD25 9LH Watford
    Segretario
    5 Wheatley Drive
    WD25 9LH Watford
    British120367360001
    PATEL, Daxshaben
    2 Millers Court
    Vicars Bridge Close
    HA0 1XG Alperton
    Middlesex
    Segretario
    2 Millers Court
    Vicars Bridge Close
    HA0 1XG Alperton
    Middlesex
    British96045520001
    WAKELEY, David Peacefull
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    166 Rosemary Hill Road
    B74 4HN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British86839080001
    WATTS, Michael
    100 Centennial Park
    Centennial Avenue, Elstree
    WD6 3SA Borehamwood
    Hertfordshire
    Segretario
    100 Centennial Park
    Centennial Avenue, Elstree
    WD6 3SA Borehamwood
    Hertfordshire
    British116124970001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEDDOW, Charles Edward Kenneth
    Manor Road
    MK45 4NU Barton Le Clay
    163
    Bedfordshire
    Amministratore
    Manor Road
    MK45 4NU Barton Le Clay
    163
    Bedfordshire
    United KingdomBritish132281430001
    BREEN, Michael John
    47 Wieland Road
    HA6 3QX Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    47 Wieland Road
    HA6 3QX Northwood
    Middlesex
    EnglandEnglish8442840002
    DAVIES, Digby John
    1a Cambridge Road
    TW1 2HN Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    1a Cambridge Road
    TW1 2HN Twickenham
    Middlesex
    British38937270002
    DAY, Barry David
    The Old Rectory Hatton Green
    Hatton
    CV35 7LA Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Rectory Hatton Green
    Hatton
    CV35 7LA Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish57937960001
    ELLIS, Robert Keith
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    55 Bushy Park Road
    TW11 9DQ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish45171010001
    EVANS, Nerys Helen
    5 St Philips Way
    Islington
    N1 7AJ London
    Amministratore
    5 St Philips Way
    Islington
    N1 7AJ London
    British66070850003
    GORDON, Neil Arthur
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Stable Cottage, Burrows Lea
    Hook Lane, Shere
    GU5 9QQ Guildford
    Surrey
    EnglandBritish73989530001
    MAKANJI, Ashok
    5 Wheatley Drive
    WD25 9LH Watford
    Amministratore
    5 Wheatley Drive
    WD25 9LH Watford
    United KingdomBritish120367360001
    MARSHALL, Nicholas John
    Spring House
    Fieldgate Lawn, Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Spring House
    Fieldgate Lawn, Fieldgate Lane
    CV8 1BT Kenilworth
    Warwickshire
    EnglandBritish20708530004
    MARTIN, Ian Paul
    Sussex Manor Business Park
    Gatwick Road
    RH10 9NH Crawley
    E2
    Sussex
    Amministratore
    Sussex Manor Business Park
    Gatwick Road
    RH10 9NH Crawley
    E2
    Sussex
    EnglandBritish31010770003
    ROBERTS, Julie Amanda
    5 St Philips Way
    Islington
    N1 7AJ London
    Amministratore
    5 St Philips Way
    Islington
    N1 7AJ London
    British57062440002
    SAMJI, Munir Akberali
    1 Lynford Close
    EN5 3HQ Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Lynford Close
    EN5 3HQ Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomUnited Kingdom119498620001
    WATTS, Michael
    Bottle Lane
    SL6 3SB Littlewick Green
    Bay Tree Cottage
    Berks
    Amministratore
    Bottle Lane
    SL6 3SB Littlewick Green
    Bay Tree Cottage
    Berks
    British133568510001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    TELECAST COMMUNICATIONS (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 feb 2004
    Consegnato il 09 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property, plant machinery vehicles computers and other equipment, stocks shares debentures bonds notes loan capital of any subsidiary any other body corporate and all rights, goodwill and uncalled capital, copyrights licences trademarks and patents, floating charge the undertaking and all property assets and rights present and future.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture between (1) the chargor (the company) and (2) national westminster bank PLC (the security trustee) as agent and trustee for the secured parties (as defined)
    Creato il 08 mag 2000
    Consegnato il 16 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the chargor to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 02 lug 1998
    Consegnato il 15 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of all or any of the financing documents (including, for the avoidance of doubt, the guarantee and debenture)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 12 mag 1998
    Consegnato il 20 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0