LEASIDE REGENERATION LIMITED

LEASIDE REGENERATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEASIDE REGENERATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 03533289
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEASIDE REGENERATION LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova LEASIDE REGENERATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    167a East India Dock Road
    Poplar
    E14 0EA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEASIDE REGENERATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LEASIDE REGENERATION LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per LEASIDE REGENERATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2016, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    18 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    18 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    22 pagineAA

    Nomina di Atanu Kumar Bhattacherjee come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew James Mahoney come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Mahoney come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Atanu Bhattacherjee come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Wilson come amministratore

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    3 pagineMR04

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    17 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Old Poplar Library 45 Gillender Street London E14 6RN* in data 18 set 2012

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Philip Callaghan come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Eric Reynolds come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di LEASIDE REGENERATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BHATTACHERJEE, Atanu Kumar
    East India Dock Road
    E14 0EA London
    167a
    Amministratore
    East India Dock Road
    E14 0EA London
    167a
    EnglandBritish121100820001
    HUNT, Neal Finbar
    8 Moat Farm
    TN2 5XG Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    8 Moat Farm
    TN2 5XG Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandIrish87131100001
    MAHONEY, Andrew James
    East India Dock Road
    E14 0EA London
    167a
    Amministratore
    East India Dock Road
    E14 0EA London
    167a
    UkBritish116492670001
    CALLAGHAN, Philip Sean
    45 Gillender Street
    E14 6RN London
    Old Poplar Library
    Segretario
    45 Gillender Street
    E14 6RN London
    Old Poplar Library
    British70461990002
    COCHRANE, William Andrew
    37 Brattlewood
    TN13 1QS Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    37 Brattlewood
    TN13 1QS Sevenoaks
    Kent
    British35592480001
    WILLIAMS, Neil Edward
    57 Albany Drive
    Walton Le Dale
    PR5 4TX Preston
    Lancashire
    Segretario
    57 Albany Drive
    Walton Le Dale
    PR5 4TX Preston
    Lancashire
    British2927950001
    BHATTACHERJEE, Atanu Kumar
    East India Dock Road
    E14 0EA London
    167a
    England
    Amministratore
    East India Dock Road
    E14 0EA London
    167a
    England
    EnglandBritish121100820001
    BIGGS, John
    7 Louisa Gardens
    E1 4NG London
    Amministratore
    7 Louisa Gardens
    E1 4NG London
    British75808570001
    BOSTOCK, Richard Mark
    Woolverstone
    IP9 1AJ Ipswich
    Riverscourt
    Suffolk
    Amministratore
    Woolverstone
    IP9 1AJ Ipswich
    Riverscourt
    Suffolk
    UkBritish103034260001
    BROWN, Ian Arthur
    61 Barrier Point Road
    E16 2SB London
    Amministratore
    61 Barrier Point Road
    E16 2SB London
    EnglandBritish68292050001
    CLARKE, Catherine Jane
    47 Grove Dwellings
    Adelina Grove
    E1 3AE London
    Amministratore
    47 Grove Dwellings
    Adelina Grove
    E1 3AE London
    British46253130002
    COCHRANE, William Andrew
    37 Brattlewood
    TN13 1QS Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    37 Brattlewood
    TN13 1QS Sevenoaks
    Kent
    British35592480001
    DALTON, Cecil
    25 Hazelwood
    IG10 4ET Loughton
    Essex
    Amministratore
    25 Hazelwood
    IG10 4ET Loughton
    Essex
    British18738900001
    DE CANI, Richard
    30 South Vale
    Upper Norwood
    SE19 3BA London
    Amministratore
    30 South Vale
    Upper Norwood
    SE19 3BA London
    British86170370001
    EDGAR, David John
    45 Gillender Street
    E14 6RN London
    Old Poplar Library
    Amministratore
    45 Gillender Street
    E14 6RN London
    Old Poplar Library
    EnglandBritish51917320001
    EDGAR, David John
    98 Copenhagen Place
    E14 7DE London
    Amministratore
    98 Copenhagen Place
    E14 7DE London
    EnglandBritish51917320001
    FARLEY, Michael John
    105 Becklow Road
    W12 9HH London
    Amministratore
    105 Becklow Road
    W12 9HH London
    UkBritish99847610001
    FEY, Susan
    Leery House 17 Parkstone Avenue
    RM11 3LX Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    Leery House 17 Parkstone Avenue
    RM11 3LX Hornchurch
    Essex
    British47044190001
    FOLKES, Yvonne
    32 Charlton Road
    N9 8EJ London
    Amministratore
    32 Charlton Road
    N9 8EJ London
    British70462090001
    FRANCIS, Marc, Councillor
    39 Connaught Works
    251 Old Ford Road
    E3 5PS London
    Amministratore
    39 Connaught Works
    251 Old Ford Road
    E3 5PS London
    United KingdomBritish125867050001
    GAUKROGER, Joanna Mary
    24 Rainville Road
    W6 9HA London
    Amministratore
    24 Rainville Road
    W6 9HA London
    United KingdomBritish53826650002
    GOODING, Richard Ernest
    84 Galaxy Building
    5 Crews Street
    E14 3SP London
    Amministratore
    84 Galaxy Building
    5 Crews Street
    E14 3SP London
    United KingdomBritish108175700011
    HILLS, John Alan
    93 Glentrammon Road
    BR6 6DQ Orpington
    Kent
    Amministratore
    93 Glentrammon Road
    BR6 6DQ Orpington
    Kent
    United KingdomBritish20765880001
    HOWE, David
    279 Southend Road
    SS11 8QA Wickford
    Essex
    Amministratore
    279 Southend Road
    SS11 8QA Wickford
    Essex
    British92540210001
    HULL, Christopher
    57 Corbin House
    Bromley High Street
    E3 3BQ London
    Amministratore
    57 Corbin House
    Bromley High Street
    E3 3BQ London
    British81599850001
    JEFFERS, Samuel John
    8 Brussels Road
    SW11 2AF London
    Amministratore
    8 Brussels Road
    SW11 2AF London
    British50781380001
    KAUR, Harbinder
    22 Chippendale Street
    E5 0BB London
    Amministratore
    22 Chippendale Street
    E5 0BB London
    British38875640002
    KELLAWAY, Alec James, Dr
    4 Garnet Walk
    Beckton
    E6 5LY London
    Amministratore
    4 Garnet Walk
    Beckton
    E6 5LY London
    United KingdomBritish83066690001
    MAHONEY, Andrew James
    East India Dock Road
    E14 0EA London
    167a
    Uk
    Amministratore
    East India Dock Road
    E14 0EA London
    167a
    Uk
    UkBritish116492670001
    MAINWARING, Julia Mary Francess
    53 Strachan Road
    Bow
    E3 5DA London
    Amministratore
    53 Strachan Road
    Bow
    E3 5DA London
    British36382780001
    MAWSON, Andrew, Lord
    Meynell Crescent
    E9 7AS London
    22
    Amministratore
    Meynell Crescent
    E9 7AS London
    22
    United KingdomBritish41785500001
    MCGREGOR, Ashton, Cllr
    7 Wellington Buildings
    Wellington Way
    E3 4NA London
    Amministratore
    7 Wellington Buildings
    Wellington Way
    E3 4NA London
    British83661570001
    MIZAN, Syed Akhtaruzzaman
    70 Chicksand House
    Chicksand Street
    E1 5LH London
    Amministratore
    70 Chicksand House
    Chicksand Street
    E1 5LH London
    British40267550002
    O'BRIEN, Robert Stephen
    16 Westferry Road
    E14 8NQ London
    170 Pierpoint
    Amministratore
    16 Westferry Road
    E14 8NQ London
    170 Pierpoint
    EnglandBritish3758070002
    ODUNOYE, Jacqueline Ruth
    115 Breamore Road
    IG3 9LX Ilford
    Essex
    Amministratore
    115 Breamore Road
    IG3 9LX Ilford
    Essex
    United KingdomBritish66724700001

    LEASIDE REGENERATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 22 dic 2003
    Consegnato il 09 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Poplar library, brunswick road, london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 ott 2003
    Consegnato il 06 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0