MARSTON VALLEY FOODS LIMITED

MARSTON VALLEY FOODS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARSTON VALLEY FOODS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03533463
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARSTON VALLEY FOODS LIMITED?

    • Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova MARSTON VALLEY FOODS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Thorpe Lea Manor
    Thorpe Lea Road
    TW20 8HY Egham
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARSTON VALLEY FOODS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ANOOVISH & ASSOCIATES LIMITED24 mar 199824 mar 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARSTON VALLEY FOODS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MARSTON VALLEY FOODS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per MARSTON VALLEY FOODS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 31 ott 2014

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    8 pagineAA

    legacy

    6 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di MARSTON VALLEY FOODS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DURRAN, Brian
    3 Cloghers
    Ballyard
    IRISH Tralee
    County Kerry
    Ireland
    Segretario
    3 Cloghers
    Ballyard
    IRISH Tralee
    County Kerry
    Ireland
    Irish7514390001
    HEALY, Flor
    Fairyhouse Lodge,
    Ratoath
    33
    Co Meath
    Ireland
    Amministratore
    Fairyhouse Lodge,
    Ratoath
    33
    Co Meath
    Ireland
    IrelandIrish145087330001
    MCCARTHY, Stan
    N Lincoln Avenue,
    Hinsdale
    60521 Chicago
    119
    Illinois 60521
    United States
    Amministratore
    N Lincoln Avenue,
    Hinsdale
    60521 Chicago
    119
    Illinois 60521
    United States
    United StatesIrish131787550001
    MEHIGAN, Brian Cornelius, Mr.
    Killelton Camp
    Tralee
    County Kerry
    Ireland
    Amministratore
    Killelton Camp
    Tralee
    County Kerry
    Ireland
    IrelandIrish103396770001
    AHLUWALIA, Sahib Singh
    13 The Glen
    Norwood Green
    UB2 5RS Southall
    Middlesex
    Segretario
    13 The Glen
    Norwood Green
    UB2 5RS Southall
    Middlesex
    British14680090001
    CHANA, Harbans Kaur
    20 Craneswater Park
    UB2 5RR Southall
    Middlesex
    Segretario
    20 Craneswater Park
    UB2 5RR Southall
    Middlesex
    British57976410001
    MARTIN, Alan Renwick
    2b The Crosspath
    WD7 8HN Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    2b The Crosspath
    WD7 8HN Radlett
    Hertfordshire
    British1776940001
    CORPORATE ADMINISTRATION SECRETARIES LIMITED
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    Segretario nominato
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    900006800001
    AHLUWALIA, Sahib Singh
    13 The Glen
    Norwood Green
    UB2 5RS Southall
    Middlesex
    Amministratore
    13 The Glen
    Norwood Green
    UB2 5RS Southall
    Middlesex
    EnglandBritish14680090001
    ANAND, Harbachan
    Ashiana
    Farm Drive Straight Road
    SL4 2NW Old Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    Ashiana
    Farm Drive Straight Road
    SL4 2NW Old Windsor
    Berkshire
    EnglandBritish14680100001
    ANDERSON, Derek Michael
    14 Hale House
    W8 5AQ London
    Amministratore
    14 Hale House
    W8 5AQ London
    English5627660001
    BRENNAN, John Edward
    Sagamore House Hedgerley Lane
    SL9 7NP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Sagamore House Hedgerley Lane
    SL9 7NP Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish48192180002
    BURTON, Thomas Bodley
    Vineyard Chapman Lane
    Well End
    SL8 5BP Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Vineyard Chapman Lane
    Well End
    SL8 5BP Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish49899370001
    CHANA, Dilbagh Singh
    44 Burns Avenue
    UB1 2LS Southall
    Middlesex
    Amministratore
    44 Burns Avenue
    UB1 2LS Southall
    Middlesex
    EnglandBritish54320390001
    CREGAN, Denis
    Lisdara
    Oakpark
    IRELAND Tralee
    County Kerry
    Amministratore
    Lisdara
    Oakpark
    IRELAND Tralee
    County Kerry
    IrelandIrish73357530001
    DUFFY, John Gerald
    Melton Road
    NG2 6JP West Bridgford
    210
    Nottingham
    Amministratore
    Melton Road
    NG2 6JP West Bridgford
    210
    Nottingham
    EnglandBritish142394810001
    FRIEL, Hugh
    Gurrane
    Listellick
    IRELAND Tralee
    County Kerry
    Ireland
    Amministratore
    Gurrane
    Listellick
    IRELAND Tralee
    County Kerry
    Ireland
    Irish50514910001
    SHARPE, Clive Richard
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    Amministratore
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    EnglandBritish134995270001
    CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    Amministratore delegato nominato
    Falcon House
    24 North John Street
    L2 9RP Liverpool
    Merseyside
    900006790001

    MARSTON VALLEY FOODS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 15 ago 2003
    Consegnato il 27 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Unit 2A colmworth business park, st neots, 5 marston road, st neots, cambridgeshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Trading as Rabobank International, Londonbranch as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Lenders (The Security Agent)
    Transazioni
    • 27 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 06 nov 2000
    Consegnato il 18 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £18562.62 (or the amount standing to the credit of the deposit account if more) due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a unit 2A colmworth business park st. Neots humtington cambrigeshire.
    Persone aventi diritto
    • Artisan (UK) Developments Limited
    Transazioni
    • 18 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 12 mag 2000
    Consegnato il 16 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 x food pack mecdrive sealing machine: s/no. FP3206; 1 x 7000 series metal detector 1 weight checker. S/no. ACB4098116803; 1 x ink jet printer s/NO79696. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 16 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 17 feb 1999
    Consegnato il 20 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    1 double d food engineering 3M cooking chamber revoband travelling cooker serial no 24608,2 ilpra systems (UK) limited sealers serial nos FP2452 and FP2467,3 bpt (skerman) limited twin tilting brat pans serial nos F3305/1,F3305/2 and F3305/3 and various other chattels for full details please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 20 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 set 1998
    Consegnato il 15 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0