AI LONDON LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAI LONDON LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03535299
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AI LONDON LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova AI LONDON LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MSQ PARTNERS LTD
    6 York Street
    W1U 6PL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AI LONDON LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ARNOLD INTERACTIVE LIMITED28 mag 200228 mag 2002
    AMX COMMUNICATIONS LIMITED16 feb 200016 feb 2000
    AMX STUDIOS LIMITED07 apr 199807 apr 1998
    RICHBIND LIMITED26 mar 199826 mar 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di AI LONDON LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per AI LONDON LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per AI LONDON LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 apr 2014

    Stato del capitale al 22 apr 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2013

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Daniel Yardley come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Peter David Reid come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Dean Wright come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 feb 2012

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Media Square Plc 6 York Street London W1U 6PL United Kingdom* in data 08 nov 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    Dettagli del segretario cambiati per Ash Shah il 21 nov 2011

    1 pagineCH03

    Nomina di Ash Shah come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Colin Brigden come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di Bruce Winfield come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Bruce Winfield come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Dean Anthony Wright come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2010

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di AI LONDON LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHAH, Ashish
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    164755030002
    REID, Peter David
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Ceo147274580002
    YARDLEY, Daniel John
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer180507300001
    BRIGDEN, Colin John
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Media Square Plc
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    147326940001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Segretario
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    BritishCompany Director75720570001
    CLARKE, Martin John
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    105 Congleton Road
    SK11 7XD Macclesfield
    Cheshire
    BritishAccountant53461320002
    HARRIS, Andrew James
    Silver Spring
    Bray Road
    SL6 1UQ Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Silver Spring
    Bray Road
    SL6 1UQ Maidenhead
    Berkshire
    BritishAccountant84825060001
    LAMING, Jeffrey Donald, Mr.
    4 Bodiam Close
    Southwater
    RH13 9XW Horsham
    West Sussex
    Segretario
    4 Bodiam Close
    Southwater
    RH13 9XW Horsham
    West Sussex
    English61836790001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Segretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    British147948820001
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Segretario
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    BritishAccountant147948820001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001
    BLOCH, Hester
    14 Denbigh Street
    SW1V 2ER London
    Amministratore
    14 Denbigh Street
    SW1V 2ER London
    BritishSales And Marketing Director92454340001
    BURNS, Graeme Ian, Mr.
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    29 Moody Street
    CW12 4AN Congleton
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director75720570001
    EVANS, Peter Frank
    29 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LR Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    29 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LR Oakham
    Leicestershire
    BritishDirector62412680002
    FRAKES, Kenneth John
    High Trees London Road
    Batchworth Hill
    WD3 1JP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    High Trees London Road
    Batchworth Hill
    WD3 1JP Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector163735010001
    FREED, Ed
    16 Bluecoat Court
    SG14 1AY Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    16 Bluecoat Court
    SG14 1AY Hertford
    Hertfordshire
    BritishI T Director92295480001
    GARRETT, Malcolm Leslie, Professor
    59 Knighthead Point
    E14 8SS London
    Amministratore
    59 Knighthead Point
    E14 8SS London
    United KingdomBritishGraphic Designer11143860001
    GREGSON, Maxine
    303 The Beaux Arts Building
    10-18 Manor Gardens
    N7 6JW London
    Amministratore
    303 The Beaux Arts Building
    10-18 Manor Gardens
    N7 6JW London
    BritishCreative Director92658900001
    HARRIS, Andrew James
    Silver Spring
    Bray Road
    SL6 1UQ Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Silver Spring
    Bray Road
    SL6 1UQ Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant84825060001
    JONES, Philip
    Flat 4 7 Brownlow Mews
    WC1N 2LD London
    Amministratore
    Flat 4 7 Brownlow Mews
    WC1N 2LD London
    BritishDirector37885270001
    MIDDLETON, Jeremy
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    Amministratore
    Corbar Hall
    Corbar Road
    SK17 6TF Buxton
    United KingdomBritishCompany Director77048380001
    O`REGAN, Simon James
    110 Plimsoll Road
    N4 2ED London
    Amministratore
    110 Plimsoll Road
    N4 2ED London
    BritishTechnical Director63203070002
    SCOTT-GODDARD, Alasdair Craig
    8 Chatsworth Court
    Powerscroft Road
    E5 0PS London
    Amministratore
    8 Chatsworth Court
    Powerscroft Road
    E5 0PS London
    BritishDirector4589860001
    SHURVILLE, Jerram
    Chess Park
    Berks Hill Chorleywood
    WD3 5AJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Chess Park
    Berks Hill Chorleywood
    WD3 5AJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director60930980002
    WINFIELD, Bruce Malcolm
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    Amministratore
    22 Hillhouse Close
    RH10 4YY Turners Hill
    West Sussex
    United KingdomBritishAccountant147948820001
    WRIGHT, Dean Anthony
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Msq Partners Ltd
    York Street
    W1U 6PL London
    6
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant159138180001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore
    120 East Road
    N1 6AA London
    54237580001

    AI LONDON LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 17 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 23 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 23 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 13-14 welbeck street, london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental deed
    Creato il 18 dic 2000
    Consegnato il 03 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the provisions of a lease of even date
    Brevi particolari
    £342,687.50 and all income and interest thereon deriving therefrom.
    Persone aventi diritto
    • Howard De Walden Estates Limited
    Transazioni
    • 03 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0