CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED

CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03540515
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CROSSCO (321) LIMITED03 apr 199803 apr 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 giu 2015

    12 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 25 giu 2015

    12 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 gen 2015

    16 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 21 lug 2014

    16 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 feb 2014

    16 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 set 2013

    25 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Sean Sullivan come amministratore

    1 pagineTM01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    13 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Cessazione della carica di Peter Short come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Peter Short come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Castlebeck Chesnut Street Darlington England DL1 1QL England* in data 13 mar 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Bilancio annuale redatto al 03 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 giu 2012

    Stato del capitale al 12 giu 2012

    • Capitale: GBP 3,600,001
    SH01

    Nomina di Sean Patrick Sullivan come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lee Reed come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Castlebeck Chestnut Street Darlington DH1 1QL England* in data 16 feb 2012

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2011 al 30 giu 2012

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Jon Hather come segretario

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lee Reed il 03 nov 2011

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIS, Kevin
    5 Castle View
    DH3 3XA Chester Le Street
    County Durham
    Segretario
    5 Castle View
    DH3 3XA Chester Le Street
    County Durham
    British11692470003
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Segretario
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    JACKSON, Allan Robert
    52 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9JF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    52 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9JF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65040980001
    QUEEN, Roger Charles
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    Segretario
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    British78822570002
    SHORT, Peter Mark Iain
    Chesnut Street
    Darlington
    DL1 1QL County Durham
    Castlebeck
    England
    Segretario
    Chesnut Street
    Darlington
    DL1 1QL County Durham
    Castlebeck
    England
    British163693200001
    DICKINSON DEES
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    Segretario nominato
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    900005460001
    BENN, Mark
    12 Ch Des Moissons
    1294 Genthod
    Switzerland
    Amministratore
    12 Ch Des Moissons
    1294 Genthod
    Switzerland
    South African114415030001
    BROSNAN, Denis
    Croom House
    Croom
    Croom
    County Limerick
    Ireland
    Amministratore
    Croom House
    Croom
    Croom
    County Limerick
    Ireland
    IrelandIrish142998660001
    BROSNAN, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomIrish102089360002
    CARE, Timothy James
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    Amministratore delegato nominato
    West House Whorlton Hall Farm
    Westerhope
    NE5 1NP Newcastle Upon Tyne
    British900005450001
    COLE, David John
    The Old Stables
    Station Road Scruton
    DL7 0QN Northallerton
    Amministratore
    The Old Stables
    Station Road Scruton
    DL7 0QN Northallerton
    British90366580005
    DAVIS, Kevin
    5 Castle View
    DH3 3XA Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Castle View
    DH3 3XA Chester Le Street
    County Durham
    British11692470003
    JACKSON, Allan Robert
    52 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9JF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    52 Linden Way
    Ponteland
    NE20 9JF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British65040980001
    MANN, Jonathan, Dr
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandBritish131435690001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Irish116537370001
    MCLEAN, Anthony
    Woodlands
    Cage End, Hatfield Broad Oak
    CM22 7HP Bishops Stortford
    Amministratore
    Woodlands
    Cage End, Hatfield Broad Oak
    CM22 7HP Bishops Stortford
    United KingdomBritish67231420002
    ORESCHNICK, Robert
    Bankfield Cold Hill Lane
    New Mill
    HD9 7JX Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bankfield Cold Hill Lane
    New Mill
    HD9 7JX Huddersfield
    West Yorkshire
    American82179080001
    PARSONS, Michael Dennis
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish44895330007
    QUEEN, Roger Charles
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78822570002
    REED, Lee
    Chesnut Street
    Darlington
    DL1 1QL County Durham
    Castlebeck
    England
    England
    Amministratore
    Chesnut Street
    Darlington
    DL1 1QL County Durham
    Castlebeck
    England
    England
    WalesBritish138692840001
    SANDHAM, Christopher John
    Old Rectory
    Ickford
    Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Old Rectory
    Ickford
    Aylesbury
    Buckinghamshire
    British83369800001
    SHORT, Peter Mark Iain
    Chesnut Street
    Darlington
    DL1 1QL County Durham
    Castlebeck
    England
    England
    Amministratore
    Chesnut Street
    Darlington
    DL1 1QL County Durham
    Castlebeck
    England
    England
    British117773420002
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    STEVENS, Brian
    16 Amerston Close
    Wynyard
    TS22 5QX Billingham
    Cleveland
    Amministratore
    16 Amerston Close
    Wynyard
    TS22 5QX Billingham
    Cleveland
    British11692460003
    SULLIVAN, Sean Patrick
    Chesnut Street
    DL1 1QL Darlington
    Castlebeck
    County Durham
    England
    Amministratore
    Chesnut Street
    DL1 1QL Darlington
    Castlebeck
    County Durham
    England
    United KingdomBritish137653030001

    CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 17 ott 2008
    Consegnato il 23 ott 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security
    Creato il 03 ott 2008
    Consegnato il 15 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Trinity house 38 carlisle road lockerbie t/no DMF4936.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security
    Creato il 03 ott 2008
    Consegnato il 15 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Monroe house 119 americanmuir road dundee t/no ANG11806.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 august 2006 and
    Creato il 10 ago 2006
    Consegnato il 02 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Trinity house 38 carlisle road lockerbie t/n DMF4936.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 29 august 2006 and
    Creato il 10 ago 2006
    Consegnato il 02 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Monroe house 119 americanmuir road dundee t/n ANG11806.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 10 ago 2006
    Consegnato il 17 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaires on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 17 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 15 mar 2005
    Consegnato il 22 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By first legal mortgage all its properties, property interests, equipment, securities, securities systems rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 22 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 17TH march 2005 and
    Creato il 11 mar 2005
    Consegnato il 05 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property k/a trinity house, 38 carlisle road, lockerbie t/no DMF4936.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 17TH march 2005 and
    Creato il 11 mar 2005
    Consegnato il 05 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any principal debtor to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property k/a 119 americanmuir road, dundee t/no ANG11806.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 11 gen 2005
    Consegnato il 14 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land at vantage park, old gloucester road, hambrook, south goucestershire, t/no GR261595. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Finance Parties)
    Transazioni
    • 14 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 15 nov 2004
    Consegnato il 18 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a the daltons dalton le dale seaham t/n DU168036. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 13 lug 2004
    Consegnato il 17 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h land k/a mowbray house, crook , county durham, t/no DU248926 fixed charge over the undertaking and all property and assets present and fuuture including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 26 mag 2004
    Consegnato il 29 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H the manor care home 93 kneeton road east bridgeford nottingham t/nos NT247018 and NT373022 all buildings fixtures and fixtures and proceeds of sale, allother interests in any other fixtures and fittings or fixed plant and machinery on the new property, insurances, present and future book and other debts benefit of all present and future agreements and authorisations in connection with the new property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Other Finance Parties)
    Transazioni
    • 29 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 09 gen 2004
    Consegnato il 20 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h property situate and known as penderels, stowell lane, meriden t/n WM447262. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Other Finance Parties
    Transazioni
    • 20 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 08 ago 2003
    Consegnato il 14 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all that f/h property situate and known as newbus grange, hurworth road, neasham, darlington t/ns DU259111, DU97175, DU55924, DU249519 and DU249518 together with all buildings and fixtures at any time thereon which belong to the company, the proceeds of sale derived therefrom and the benefit of all covenants given in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Other Finance Parties
    Transazioni
    • 14 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 15TH august 2002 and
    Creato il 12 lug 2002
    Consegnato il 28 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from each obligor (including the company and the debtor) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Munroe house,macalpine road/americanmuir road,dundee,county of angus with all buildings,fittings and fixtures thereon and all right,title and interest therein. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Finance Parties
    Transazioni
    • 28 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 15TH august 2002 and
    Creato il 12 lug 2002
    Consegnato il 28 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from each obligor (including the company and the debtor) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    38 carlisle rd,lockerbie DG11 2DS; t/no dmf 4936 with all buildings,fittings and fixtures thereon and all right,title and interest therein. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Finance Parties
    Transazioni
    • 28 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    5
    Creato il 12 lug 2002
    Consegnato il 02 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Victoria house 30/31 victoria embankment darlington freehold t/n DU125888 and DU152551, thornfield grange 60 etherley lane bishop auckland freehold t/n DU191230, whorlton hall whorlton village barnard castle county durham freehold t/n DU225411 (for further details of property charged see schedule to 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Other Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 31ST may 2002
    Creato il 10 mag 2002
    Consegnato il 22 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Area of ground at the junction of macalpine road and americanmuir road in the city of dundee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 22ND june 2001
    Creato il 06 lug 2000
    Consegnato il 05 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Trinity house 38 carlisle road lockerbie.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Creato il 02 ago 1999
    Consegnato il 14 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Life of brian stevens for £500,000 dated 10/5/99,policy no.50-48L-das in favour of allied dunbar assurance PLC with all sums,bonuses and benefits thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charge
    Creato il 30 nov 1998
    Consegnato il 02 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CASTLEBECK CARE HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 mar 2013Inizio dell'amministrazione
    25 giu 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Joseph Peter Francis Mclean
    Grant Thornton Uk Llp
    1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    1 Whitehall Riverside,Whitehall Road
    LS1 4BN Leeds
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0