WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY

WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 03543429
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Indirizzo della sede legale
    27 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLACKSTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY03 apr 199803 apr 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    16 pagineAA

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 15 lug 2022

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeremy David Cape il 22 nov 2021

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    17 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jeremy David Cape il 05 ago 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    12 pagineMA

    Nomina di Mr Jeremy David Cape come amministratore in data 25 feb 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Nasir Pasha come amministratore in data 25 feb 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mahmoud Raafat come amministratore in data 25 feb 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Liam Cunningham come amministratore in data 25 feb 2021

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    21 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Raglan Real Estate Acquisition Company come persona con controllo significativo il 01 ago 2019

    5 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Maybourne Hotel Group 41-43 Brook Street Mayfair London W1K 4HJ England a 27 Knightsbridge London SW1X 7LY in data 01 ago 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAPE, Jeremy David
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Amministratore
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarBritish,Argentine280421610001
    PASHA, Nasir
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Amministratore
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarBritish280348180001
    SOCKER, Marc Nathan
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Amministratore
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    United KingdomBritish253588970001
    DOWD, Thomas Patrick
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Segretario
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Irish93945640001
    EDWARDS, Sara Louise
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    Segretario
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    British108281650001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Segretario
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Segretario
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GIBBONS, Clive Anthony
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    Segretario
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    British74719200002
    GRAY, Jonathan David
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Segretario
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Usa65836770001
    WALKER, Carole
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Segretario
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    British138522860001
    ALDEN, Stephen Jude
    c/o Maybourne Hotel Group
    Vine Street
    Mayfair
    W1J 0AH London
    1
    England
    Amministratore
    c/o Maybourne Hotel Group
    Vine Street
    Mayfair
    W1J 0AH London
    1
    England
    United KingdomMaltese115411150008
    ALLEN, David Weston
    8 Merton Walk
    Mount Saint Annes
    6 Milltown
    Dublin
    Ireland
    Amministratore
    8 Merton Walk
    Mount Saint Annes
    6 Milltown
    Dublin
    Ireland
    Irish99989350001
    BAKHOS, Fady
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Amministratore
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    QatarFrench206158260001
    BARRACK JR, Thomas Joseph
    PO BOX 358
    Santa Ynez
    California 93460
    Usa
    Amministratore
    PO BOX 358
    Santa Ynez
    California 93460
    Usa
    American58370240001
    CERIALE, John Victor
    13 Prospect Road
    Westport
    Ct 06880
    Usa
    Amministratore
    13 Prospect Road
    Westport
    Ct 06880
    Usa
    Usa65836740001
    CUNNINGHAM, Liam
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Amministratore
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    IrelandIrish198255770001
    DONNELLY, Peter Joseph
    104 Avoca Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    104 Avoca Park
    Blackrock
    Co. Dublin
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish93945650001
    DOWD, Thomas Patrick
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Tisrara
    Ballyowen Lane
    Lucan
    Co Dublin
    Ireland
    United KingdomIrish93945640001
    EDWARDS, Sara Louise
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    Amministratore
    6 Mardle Close
    LU1 4EZ Caddington
    Bedfordshire
    United KingdomBritish108281650001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Amministratore
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritish50060390001
    GIBBONS, Clive Anthony
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    Amministratore
    5 Four Acre Coppice
    RG27 9NF Hook
    Hampshire
    EnglandBritish74719200002
    GRAY, Jonathan David
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Amministratore
    200 East 72nd Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Usa65836770001
    HENNEBRY, Mark Nicholas
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    Amministratore
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    IrelandIrish128404490001
    KUKRAL, John Zavertnik
    8 Rocky Point Road
    Old Greenwich
    Connecticut
    06870
    Usa
    Amministratore
    8 Rocky Point Road
    Old Greenwich
    Connecticut
    06870
    Usa
    United StatesAmerican167484790001
    MCKENNA, Geraldine Maria Martina
    31 Clancarty Road
    SW6 3AH London
    Amministratore
    31 Clancarty Road
    SW6 3AH London
    United KingdomIrish93995420001
    RAAFAT, Mahmoud
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    Amministratore
    SW1X 7LY London
    27 Knightsbridge
    United Kingdom
    QatarEgyptian271030610001
    REYNOLDS, Paul
    30 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    Amministratore
    30 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    EnglandBritish108281880001
    SEELINGER, Lisa Eleonora
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    Amministratore
    C/O Maybourne Hotels Ltd
    30 Old Burlington Street
    W1S 3AR Mayfair London
    United KingdomAmerican128749960002
    WALKER, Carole
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    Amministratore
    c/o Maybourne Hotel Group
    Brook Street
    Mayfair
    W1K 4HJ London
    41-43
    England
    EnglandBritish138522860001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Raglan Real Estate Acquisition Company
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    06 apr 2016
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    No
    Forma giuridicaPrivate Unlimited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House, England & Wales
    Numero di registrazione03558968
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    WESTONE HOTEL ACQUISITIONS COMPANY ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 gen 2015
    Consegnato il 30 gen 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited as Common Security Trustee (As Trustee for Each of the Finance Parties)
    Transazioni
    • 30 gen 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 dic 2012
    Consegnato il 08 gen 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each debtor to any common secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 08 gen 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 12 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee and each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transazioni
    • 12 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over a bank account
    Creato il 01 apr 2011
    Consegnato il 12 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The account and the account balance. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transazioni
    • 12 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 mag 2008
    Consegnato il 19 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 19 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 30 mag 2008
    Consegnato il 19 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 19 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Account charge
    Creato il 29 giu 2006
    Consegnato il 19 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its present and future rights title interest and benefit whatsoever present and future in and to the interest reserve account and the interest reserve account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Account charge
    Creato il 23 set 2005
    Consegnato il 13 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title interest and benefit in and to the interest reserve account and the interest reserve account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 set 2005
    Consegnato il 11 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings and fixtures,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 14 mag 2004
    Consegnato il 03 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC in Its Capacity as Trustee for the Secured Parties (Thesecurity Trustee)
    Transazioni
    • 03 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Junior mortgage of shares
    Creato il 05 gen 1999
    Consegnato il 15 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties) andto the finance (junior agent) parties (as defined) under each finance document (as defined) to which the company is a party
    Brevi particolari
    All the shares; and all related rights accruing to the shares.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company
    Transazioni
    • 15 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Senior mortgage of shares
    Creato il 05 gen 1999
    Consegnato il 15 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the finance parties) and to the finance parties (as defined) under each finance document (as defined) to which the company is a party
    Brevi particolari
    All the shares; and all related rights accrusing to the shares.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company
    Transazioni
    • 15 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of amendment and restatement(originally dated 7/4/98)
    Creato il 30 apr 1998
    Consegnato il 09 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under each finance document to which the company is a party
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 09 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between the company and merrill lynch international (the security trustee),as amended by the deed of amendment and restatement dated 30/4/98
    Creato il 07 apr 1998
    Consegnato il 11 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company to any finance party under each finance document to which the company is a party
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Merrill Lynch International (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 11 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0