NITRAM ENTERPRISES LIMITED

NITRAM ENTERPRISES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNITRAM ENTERPRISES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03543871
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NITRAM ENTERPRISES LIMITED?

    • Attività di contabilità e revisione (69201) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova NITRAM ENTERPRISES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    326 Heaton Road
    Heaton
    NE6 5QH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di NITRAM ENTERPRISES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per NITRAM ENTERPRISES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Michael Shaun Martin come amministratore in data 10 apr 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jennifer Martin come amministratore in data 10 apr 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 feb 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Nomina di Mrs Jennifer Martin come amministratore in data 10 feb 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2016

    Stato del capitale al 31 mar 2016

    • Capitale: GBP 20
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Shaun Martin il 28 mar 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 apr 2015

    Stato del capitale al 03 apr 2015

    • Capitale: GBP 20
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Shaun Martin il 28 mar 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di NITRAM ENTERPRISES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, Michael Shaun
    30a York Place
    EH1 3EP Edinburgh
    Lothian
    Segretario
    30a York Place
    EH1 3EP Edinburgh
    Lothian
    British57713580005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    MARTIN, Alison
    18 Tomatin Road
    IV2 4UA Inverness
    Scotland
    Amministratore
    18 Tomatin Road
    IV2 4UA Inverness
    Scotland
    British57713570001
    MARTIN, Jennifer
    St. Bernards Row
    EH4 1HW Edinburgh
    5e
    Scotland
    Amministratore
    St. Bernards Row
    EH4 1HW Edinburgh
    5e
    Scotland
    ScotlandBritish222749250001
    MARTIN, Michael Shaun
    St. Bernards Row
    EH4 1HW Edinburgh
    5e
    Scotland
    Amministratore
    St. Bernards Row
    EH4 1HW Edinburgh
    5e
    Scotland
    ScotlandBritish57713580006

    Chi sono le persone con controllo significativo di NITRAM ENTERPRISES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mrs Jennifer Martin
    St. Bernards Row
    EH4 1HW Edinburgh
    5e
    Scotland
    10 feb 2017
    St. Bernards Row
    EH4 1HW Edinburgh
    5e
    Scotland
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Scotland
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    NITRAM ENTERPRISES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 01 mar 2004
    Consegnato il 19 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    31 sunbury avenue jesmond newcastle upon tyne fixed charge over all rental income and the proceeds of sale of any lease of the property. Floating charge over the undertaking all property assets and rights of the company.
    Persone aventi diritto
    • Capital Home Loans Limited
    Transazioni
    • 19 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 13TH january 2000
    Creato il 13 dic 1999
    Consegnato il 27 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 7/17 new cut rigg craighall road edinburgh (south westmost flatted house on fourth floor entering by the common entrance and stair 7 new cut rigg craighall road edinburgh and car parking space 40 of the relevant development).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 20 nov 1998
    Consegnato il 28 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at 3 burnside spital tongues newcastle upon tyne t/no TY199210. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 20 nov 1998
    Consegnato il 28 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at 31 sunbury avenue jesmond tyne and wear. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1998
    Consegnato il 03 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property at 198 sandyford road newcastle upon tyne t/no: TY128762. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 ott 1998
    Consegnato il 03 nov 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at 62 cardigan terrace heaton t/no: TY124010. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 nov 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 07 lug 1998
    Consegnato il 18 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 lug 1998
    Consegnato il 18 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 20B clayton street west newcastle upon tyne-TY262538. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 lug 1998
    Consegnato il 18 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 83 cartington terrace heaton newcastle upon tyne-TY106928. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0