MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD

MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMACHIN YORKSHIRE LAMB LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03546111
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD?

    • Lavorazione e conservazione della carne (10110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLARINE LIMITED15 apr 199815 apr 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2019

    6 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 apr 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2018

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2016

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 apr 2016

    Stato del capitale al 20 apr 2016

    • Capitale: GBP 600,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 apr 2015

    Stato del capitale al 29 apr 2015

    • Capitale: GBP 600,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 apr 2014

    Stato del capitale al 22 apr 2014

    • Capitale: GBP 600,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Edward Machin il 15 apr 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MACHIN, Wendy Elizabeth
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    Segretario
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    British41134850001
    MACHIN, Richard Edward
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    North Yorkshire
    EnglandBritish19957810001
    EVANS, Roger David Loveden
    Mill House
    Ripley
    HG3 3EB Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    Mill House
    Ripley
    HG3 3EB Harrogate
    North Yorkshire
    British31795090001
    MACHIN, Richard Edward
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    North Yorkshire
    Segretario
    Low Farm
    Brandsby
    YO61 4RW York
    North Yorkshire
    British19957810001
    TURNER, Paul Robert
    9 Swainsea Lane
    YO18 8NE Pickering
    North Yorkshire
    Segretario
    9 Swainsea Lane
    YO18 8NE Pickering
    North Yorkshire
    British26819050002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    EVANS, Roger David Loveden
    Mill House
    Ripley
    HG3 3EB Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Mill House
    Ripley
    HG3 3EB Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish31795090001
    HAWORTH, Peter
    Newstead Grange
    Thirsk Road
    YO6 3NH Easingwold
    North Yorkshire
    Amministratore
    Newstead Grange
    Thirsk Road
    YO6 3NH Easingwold
    North Yorkshire
    United KingdomBritish58835860001
    MACHIN, John Parkin
    West Lodge
    Brandsby
    YO6 4RH York
    North Yorkshire
    Amministratore
    West Lodge
    Brandsby
    YO6 4RH York
    North Yorkshire
    British20027310001
    SIDAWAY, Paul
    2 Hengell
    Uchaf New Road
    SA45 9SE New Quay
    Ceredigion
    Amministratore
    2 Hengell
    Uchaf New Road
    SA45 9SE New Quay
    Ceredigion
    British100271160001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Richard Edward Machin
    Brandsby
    YO61 4RW York
    Low Farm
    North Yorkshire
    England
    15 apr 2016
    Brandsby
    YO61 4RW York
    Low Farm
    North Yorkshire
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.

    MACHIN YORKSHIRE LAMB LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 18 set 2006
    Consegnato il 19 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 21.4 acres of land or thereabouts at bradsby north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 09 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 set 2006
    Consegnato il 19 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a thornhill farm and land at brandsby in the county of north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 10 mag 2006
    Consegnato il 13 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    2 x evaporator type no. SOP0019779; 2 x evaporator type no. SOP0019772; 2 evaporator type no. SOP0019773 (for details of further items charged please refer to form 395) together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books manuals handbooks technical data drawings schedules and other documentation (or any amendments to them) belonging to the items listed.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H seaves farm, low farm, water end, mill hill farm, brandsby mill land and buildings on the north side of brandsby bank, home farm, spellar park and land and buildings adjoining brandsby t/no P43500.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings lying to the south east of the road leading from skipton on swale to carlton minuat, busby stoop and knackers yard busby stoop t/nos NYK70514, NYK164481 and NYK267852.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H west lodge town street brandsby t/no YK877.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the west side of jail lane stearsby and land lying to the east of low farm brandsby york t/nos NYK265447 & NYK265448.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 29 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 giu 2004
    Consegnato il 23 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 23 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 dic 2003
    Consegnato il 19 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Knackers yard busby stoop thirsk north yorkshire t/n NYK164481. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 feb 2003
    Consegnato il 20 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Knackers yard busby stoop thirsk north yorkshire NYK164481. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 2003
    Consegnato il 17 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the south east of the road leading from skipton-on-swale to carlton miniott busby stoop thirsk hambleton north yorkshire title number NYK267852. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 giu 2002
    Consegnato il 01 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Wenvoe busby stoop thirsk north yorkshire YO7 4EH.
    Persone aventi diritto
    • Robert Edgar Hawken and Kathleen Mary Hawken
    Transazioni
    • 01 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 gen 2000
    Consegnato il 20 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a the abattoir busby stoop nr thirsk north yorkshire. T/no. NYK70514. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 mag 1999
    Consegnato il 27 mag 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 giu 1998
    Consegnato il 18 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum of £150,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings lying to the south east of the road leading from skipton-on-swale to carlton miniott busby stoop.t/no.NYK70514.
    Persone aventi diritto
    • Abbeyville Associates Limited
    Transazioni
    • 18 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0