RAZORFISH UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RAZORFISH UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03547882 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RAZORFISH UK LIMITED?
- Agenzie pubblicitarie (73110) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova RAZORFISH UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pembroke Building Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RAZORFISH UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| AVENUE A / RAZORFISH LTD | 25 giu 2007 | 25 giu 2007 |
| DNA CONSULTING LIMITED | 17 apr 1998 | 17 apr 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RAZORFISH UK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per RAZORFISH UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Nicola Raj come segretario in data 07 giu 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Raj Basran come segretario in data 18 gen 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Nigel Gregory Vaz come amministratore in data 19 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Guy David Mark Elliott come amministratore in data 19 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 28 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Michael Karg come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Miss Joanne Munis come segretario in data 07 apr 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sarah Anne Bailey come segretario in data 02 apr 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher John Mellish come amministratore in data 21 gen 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Karg come amministratore in data 07 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Ariel Marciano come amministratore in data 07 nov 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Graham Arthur Devenish Mears come amministratore in data 07 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joseph Tomasulo come amministratore in data 24 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 17 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di RAZORFISH UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNIS, Joanne | Segretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | 196669800001 | |||||||
| RAJ, Nicola | Segretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building United Kingdom | 233357160001 | |||||||
| ELLIOTT, Guy David Mark | Amministratore | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | England | British | 205439450001 | |||||
| MARCIANO, Ariel | Amministratore | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | United States | French | 193315280001 | |||||
| VAZ, Nigel Gregory | Amministratore | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | England | British | 217376590001 | |||||
| BAILEY, Sarah Anne | Segretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | 185511020001 | |||||||
| BASRAN, Raj | Segretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | 169964510001 | |||||||
| COTTON, Brian John Powell | Segretario | Hardwycke House Knott Park KT22 0HZ Oxshott Surrey | British | 5682160001 | ||||||
| DAVIS, Robert | Segretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | British | 155474870001 | ||||||
| FISHER, Richard Ian Brook | Segretario | 30 Chestnut Avenue KT10 8JF Esher Surrey | British | 3846110001 | ||||||
| GONZALEZ-GOMEZ, Minna Katriina | Segretario | Avonmore Road Kensington Village W14 8DG London Pembroke Building | British | 147171230001 | ||||||
| KNIBB, Richard Trevor | Segretario | Oak Gates Acrefield Road SL9 8NA Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 76363180001 | ||||||
| MEARS, Graham | Segretario | 19b Claxton Grove W6 8HD London | British | 104248560001 | ||||||
| WALLS ECKLEY, Gillian | Segretario | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | 160069310001 | |||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| RB SECRETARIAT LIMITED | Segretario | Third Floor, 20 Primrose Street, EC2A 2RS London The Broadgate Tower, | 38862050002 | |||||||
| TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Segretario | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
| BERINGER, Stephen | Amministratore | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | England | German | 150658100001 | |||||
| COTTON, Brian John Powell | Amministratore | Hardwycke House Knott Park KT22 0HZ Oxshott Surrey | United Kingdom | British | 5682160001 | |||||
| CUNNINGHAM, John James | Amministratore | 13 Manor Court Leigham Avenue SW16 2DS London | British | 79958470002 | ||||||
| DOLLIVER, Keith Ranger | Amministratore | 5580 179th Avenue S.E Bellevue Washington 98006 U.S.A | U.S.A. | American | 102377980001 | |||||
| ENGLAND-HALL, Stephen | Amministratore | Kensington Villiage Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | England | New Zealander | 147171100001 | |||||
| HOPTON, Paul Carlyle | Amministratore | 11a Jacksons Lane N6 5SR London | British | 59747490001 | ||||||
| JARMAN PRICE, Russell | Amministratore | The Blue House 6 Station Road TW12 2BX Hampton Village Middlesex | British | 70474020003 | ||||||
| KARG, Michael | Amministratore | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | Usa | Austrian | 193710020001 | |||||
| KRUEGER, Garrett Reid | Amministratore | 11125 Champagne Point Road Nne Kirkland Washington 98034 Usa | American | 114119730002 | ||||||
| LAWRENCE, Robert Alan | Amministratore | The Coach House 69 Matthias Road N16 8NW London | England | British | 65210490003 | |||||
| MEARS, Graham Arthur Devenish | Amministratore | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building | South Africa | British,South African | 151766000001 | |||||
| MEARS, Graham | Amministratore | 19b Claxton Grove W6 8HD London | British | 104248560001 | ||||||
| MELLISH, Christopher John | Amministratore | Kensington Village Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | England | British | 157786500001 | |||||
| MELLISH, Christopher John | Amministratore | 60a Ackroyd Road Forest Hill SE23 1DL London | British | 108609970001 | ||||||
| METZGER, Keith Michael | Amministratore | 4612 177th Avenue Se Bellevue 98006 Wa Usa | American | 109603950001 | ||||||
| MILLER, Neil | Amministratore | Nicosia Road SW18 3RN London 17 | England | British | 152582780001 | |||||
| MILLER, Paul | Amministratore | Meadow View Miles Lane KT11 2YD Cobham Surrey | England | British | 58317820001 | |||||
| ORNDORFF, Benjamin Owen | Amministratore | 9333 Se 47th Street Mercer Island Washington 98040 U.S.A. | United States | American | 105121140010 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RAZORFISH UK LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mms Uk Holdings Limited | 06 apr 2016 | Avonmore Road W14 8DG London Pembroke Building England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
RAZORFISH UK LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture containing fixed and floating charges | Creato il 12 giu 2003 Consegnato il 13 giu 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 13 ott 1999 Consegnato il 20 ott 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 19 ago 1999 Consegnato il 02 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an underlease of even date | |
Brevi particolari The amount standing to the credit of a designated deposit account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0