ASMMC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASMMC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03548695
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASMMC LIMITED?

    • (7260) /

    Dove si trova ASMMC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Mansion House
    Benham Valence
    RG20 8LU Newbury
    Berks
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASMMC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CSTIM LIMITED17 apr 199817 apr 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASMMC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ASMMC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    16 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Simon Derek Burt il 20 set 2011

    3 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 mag 2011

    • Capitale: GBP 1.04
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 17 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Terence William Burt il 22 feb 2011

    2 pagineCH01

    legacy

    38 pagineMG01

    legacy

    10 pagineMG01

    Indirizzo della sede legale modificato da Profile West 950 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9EE United Kingdom in data 01 ott 2010

    2 pagineAD01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Agreements 19/07/2010
    RES13

    legacy

    30 pagineMG01

    legacy

    9 pagineMG01

    Nomina di Simon Derek Burt come amministratore

    3 pagineAP01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2010 al 31 dic 2010

    3 pagineAA01

    Nomina di Nicholas Paul Grossman come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Terence William Burt come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Nicholas Paul Grossman come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Suzanne Chase come segretario

    2 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di ASMMC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GROSSMAN, Nicholas Paul
    St. Margarets Road
    TW1 1PW Twickenham
    343
    Middlesex
    Segretario
    St. Margarets Road
    TW1 1PW Twickenham
    343
    Middlesex
    British152276380001
    BURT, Simon Derek
    Lansdowne Road
    BN11 4NA Worthing
    25
    England
    Amministratore
    Lansdowne Road
    BN11 4NA Worthing
    25
    England
    EnglandBritishDirector115791650002
    BURT, Terence William
    One Wycombe Square
    W8 7JF London
    Flat 25
    United Kingdom
    Amministratore
    One Wycombe Square
    W8 7JF London
    Flat 25
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director73890540004
    GROSSMAN, Nicholas Paul
    St. Margarets Road
    TW1 1PW Twickenham
    343
    Middlesex
    Amministratore
    St. Margarets Road
    TW1 1PW Twickenham
    343
    Middlesex
    United KingdomBritishManager157544150001
    CAMERON, Lee John Harcourt
    58 Green Street
    WD3 5QR Chorleywood
    Hertfordshire
    Segretario
    58 Green Street
    WD3 5QR Chorleywood
    Hertfordshire
    British76251460003
    CHASE, Suzanne Gabrielle
    Heathfield Terrace
    W4 4JE Chiswick
    24
    United Kingdom
    Segretario
    Heathfield Terrace
    W4 4JE Chiswick
    24
    United Kingdom
    BritishSolicitor135246350002
    CHRISTOPHOROU, Steven Richard
    Adrian Road
    WD5 0AQ Abbots Langley
    12
    Hertfordshire
    Uk
    Segretario
    Adrian Road
    WD5 0AQ Abbots Langley
    12
    Hertfordshire
    Uk
    BritishSolicitor132483000001
    HARRIS, Karen
    36 Wayside Avenue
    Bushey
    WD23 4SQ Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    36 Wayside Avenue
    Bushey
    WD23 4SQ Watford
    Hertfordshire
    British40834090003
    SANDISON, Nicholas Andrew Macdonald
    1 Dawes Lane
    Sarratt
    WD3 6BA Rickmansworth
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Dawes Lane
    Sarratt
    WD3 6BA Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishLawyer100721440002
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    LINDEMANN LINDSAY
    Suite 513 5th Floor Africa House
    64-78 Kingsway
    WC2B 6BG London
    Segretario
    Suite 513 5th Floor Africa House
    64-78 Kingsway
    WC2B 6BG London
    68688700001
    ALCOCK, Kevin Robert
    Derby Road
    GU27 1BP Haslemere
    Doyle House
    Surrey
    Uk
    Amministratore
    Derby Road
    GU27 1BP Haslemere
    Doyle House
    Surrey
    Uk
    EnglandBritishConsultant135964000001
    BERESFORD, David Michael
    Otterbourne Road
    Compton
    SO21 2BB Winchester
    The Coach House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Otterbourne Road
    Compton
    SO21 2BB Winchester
    The Coach House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director136196730001
    BOWER, David George Clifford
    Catsland Farmhouse
    Bramlands Lane
    BN5 9TG Woodmancote
    West Sussex
    Amministratore
    Catsland Farmhouse
    Bramlands Lane
    BN5 9TG Woodmancote
    West Sussex
    BritishDirector120738860001
    BURTON, Alan Christopher
    The Coach House
    Marly Knowe, Windygates Road
    EH39 4QP North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    The Coach House
    Marly Knowe, Windygates Road
    EH39 4QP North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritishRetired Co Director59221290001
    CHARLES, Jeremy Douglas
    29 Middleton Road
    NW11 7NR London
    Amministratore
    29 Middleton Road
    NW11 7NR London
    EnglandBritishConsultant19690700002
    CONNOR, James Michael
    17d Kings Road
    TW10 6NN Richmond
    Surrey
    Amministratore
    17d Kings Road
    TW10 6NN Richmond
    Surrey
    CanadianManagement Consultant79013050001
    CRUICKSHANK, Stuart
    13 Gloucester Road
    W5 4JB London
    Amministratore
    13 Gloucester Road
    W5 4JB London
    EnglandBritishAccountant114599790001
    DALLAS, John Scott
    Zouches Farm
    Dunstable Road
    LU1 4AP Caddington
    The Grange
    Bedfordshire
    Amministratore
    Zouches Farm
    Dunstable Road
    LU1 4AP Caddington
    The Grange
    Bedfordshire
    United KingdomBritishConsultant122560090002
    DE NICOLA, Lionel Jules Rene
    Protea Heights
    Martingale Avenue
    Hout Bay
    7806
    South Africa
    Amministratore
    Protea Heights
    Martingale Avenue
    Hout Bay
    7806
    South Africa
    FrenchConsultant68455510001
    DODD, Eric Stephen
    33 Lawn Crescent
    TW9 3NS Richmond
    Surrey
    Amministratore
    33 Lawn Crescent
    TW9 3NS Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishGroup Finance Director113939500001
    HARVEY, Terence
    Riddings Farm
    Hanbury Road, Anslow
    DE13 9QT Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Riddings Farm
    Hanbury Road, Anslow
    DE13 9QT Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector29863610002
    HAY, Douglas Stephen
    Mandalay
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    Amministratore
    Mandalay
    Duncrievie
    PH2 9PD Glenfarg
    Perthshire
    BritishInvestment Manager1223250004
    HOBBS, Martin Kenneth
    24 Elgin Crescent
    W11 2JR London
    Amministratore
    24 Elgin Crescent
    W11 2JR London
    United KingdomSouth AfricanLawyer113652560001
    JAMES, Gavin Keith, Mr.
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Camelford
    Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director44173560008
    LUMER, Dean John
    8 Janmead
    Hutton
    CM13 2PU Brentwood
    Essex
    Amministratore
    8 Janmead
    Hutton
    CM13 2PU Brentwood
    Essex
    EnglandBritishDirector81310430001
    MCINTYRE, Duncan James
    Chesters
    Orchard Way
    KT10 9DY Esher
    Surrey
    Amministratore
    Chesters
    Orchard Way
    KT10 9DY Esher
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director41795980002
    MILLWARD, Guy Leighton
    KT7
    Amministratore
    KT7
    United KingdomBritishFinance Director203759730001
    PHILLIPS, Michael Scott
    Criafolen 13 Daneswood Close
    KT13 9AY Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Criafolen 13 Daneswood Close
    KT13 9AY Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishGroup Finance Director59751680001
    ROBINSON, Boyd
    Flat 6
    57 Sinclair Road
    W14 0NR London
    Amministratore
    Flat 6
    57 Sinclair Road
    W14 0NR London
    United KingdomBritishAccountant82244620001
    STEWART, Andrew Martin
    The Manor
    High Street
    MK16 9NB Sherington
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Manor
    High Street
    MK16 9NB Sherington
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector169598350001
    SUMMERS, Andrew John Sibbald
    27 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    Amministratore
    27 Parkwood Road
    Wimbledon
    SW19 7AQ London
    BritishInvestment Manager42068840001
    WARD, Hugh Roderick
    Sunset Lodge
    La Rue De Haute
    JE3 8AR St Brelade
    Jersey
    Amministratore
    Sunset Lodge
    La Rue De Haute
    JE3 8AR St Brelade
    Jersey
    JerseyBritishInvestment Company Executive89956550001
    CHETTLEBURGH'S LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Amministratore delegato nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000850001

    ASMMC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A confirmatory debenture
    Creato il 02 feb 2011
    Consegnato il 14 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Europe Limited (The Security Agent)
    Transazioni
    • 14 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 14 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hutton Collins Capital Partners Iii
    Transazioni
    • 14 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of accession
    Creato il 21 lug 2010
    Consegnato il 30 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, credit balances, insurances and other contracts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Europe Limited as Agent and Trustee for Itself and Each of the Secured Creditors (The Security Agent)
    Transazioni
    • 30 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of accession
    Creato il 21 lug 2010
    Consegnato il 28 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hutton Collins Capital Partners Iii
    Transazioni
    • 28 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2007
    Consegnato il 12 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mar 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Rent deposit deed
    Creato il 03 dic 2004
    Consegnato il 07 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £27,500.00.
    Persone aventi diritto
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transazioni
    • 07 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 29 lug 1999
    Consegnato il 31 lug 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the rent deposit deed dated 29 july 1999
    Brevi particolari
    The sum deposit is £27,500.
    Persone aventi diritto
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transazioni
    • 31 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 26 mag 1998
    Consegnato il 02 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0