RIGHTS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRIGHTS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03550368
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RIGHTS LTD?

    • Creazione artistica (90030) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova RIGHTS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    7 East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    West Sussex
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RIGHTS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HALLCO 215 LIMITED22 apr 199822 apr 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di RIGHTS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per RIGHTS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2022

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020

    9 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2019

    10 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Minkow come segretario in data 30 ott 2020

    2 pagineAP03

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Legacy Books Limited come persona con controllo significativo il 07 nov 2019

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Jonathan Naggar come amministratore in data 22 mag 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Marion Naggar come amministratore in data 22 mag 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles Waite Morgan come amministratore in data 22 mag 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Caroline Jayne Michel come amministratore in data 22 mag 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kevin Allan Jones come amministratore in data 22 mag 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Scott Hoffman come amministratore in data 22 mag 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Hilary Strong come amministratore in data 22 mag 2020

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 55 New Oxford Street London WC1A 1BS England a 7 East Pallant Chichester West Sussex PO19 1TR in data 27 mag 2020

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per The Honourable Marion Naggar il 08 ott 2018

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di RIGHTS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MINKOW, Andrew
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    Segretario
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    276063220001
    HOFFMAN, Scott
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    United StatesAmericanChief Executive Officer269072320001
    STRONG, Hilary
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive Officer260567270001
    AGGETT, Paul Bernard
    34-43 Russell Street
    WC2B 5HA London
    Drury House
    Segretario
    34-43 Russell Street
    WC2B 5HA London
    Drury House
    British191240490001
    BEALE, Philip Arthur
    32 Laburnum Grove
    SS5 4SG Hockley
    Essex
    Segretario
    32 Laburnum Grove
    SS5 4SG Hockley
    Essex
    British50643540001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Segretario nominato
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    AGGETT, Paul Bernard
    Hadleigh Road
    East Bergholt
    CO7 6QT Colchester
    Gatton House
    Uk
    Amministratore
    Hadleigh Road
    East Bergholt
    CO7 6QT Colchester
    Gatton House
    Uk
    United KingdomBritishFinance Director147255650001
    BANKS, Jeremy Loch Mansell
    27 Campana Road
    SW6 4AT London
    Amministratore
    27 Campana Road
    SW6 4AT London
    BritishDirector66985130003
    BEALE, Philip Arthur
    32 Laburnum Grove
    SS5 4SG Hockley
    Essex
    Amministratore
    32 Laburnum Grove
    SS5 4SG Hockley
    Essex
    United KingdomBritishBudgetary Controller50643540001
    DOWNING, Terry William
    52 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    Amministratore
    52 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    EnglandBritishDirector109287950001
    DURKAN, Mary Margaret
    34-43 Russell Street
    WC2B 5HA London
    Drury House
    Amministratore
    34-43 Russell Street
    WC2B 5HA London
    Drury House
    EnglandBritishDirector42948540002
    FOSTER, Michael Adam
    Russell Street
    WC2B 5HA London
    Drury House 34-43
    United Kingdom
    Amministratore
    Russell Street
    WC2B 5HA London
    Drury House 34-43
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector55961850005
    GARDNER, Malcolm William
    18 Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    Amministratore
    18 Elm Grove Road
    Ealing
    W5 3JJ London
    EnglandBritishDirector101769350001
    JONES, Kevin Allan
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director209706570001
    LANE, David Charles William
    55 Mendip Court
    Riverside Plaza
    SW11 Wandsworth
    Amministratore
    55 Mendip Court
    Riverside Plaza
    SW11 Wandsworth
    BritishManaging Director58001940003
    MICHEL, Caroline Jayne
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector146138640001
    MORGAN, Charles Waite
    Chester Street
    SW1X 7BL London
    18
    Uk
    Amministratore
    Chester Street
    SW1X 7BL London
    18
    Uk
    United KingdomAustralianNone160539840002
    MURPHY, Susan Margaret
    Windwhistle
    Pinner Hill
    HA5 3XY Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    Windwhistle
    Pinner Hill
    HA5 3XY Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector49990470002
    NAGGAR, Jonathan
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector44844270003
    NAGGAR, Marion, The Honourable
    New Cavendish Street
    W1G 8UB London
    34
    United Kingdom
    Amministratore
    New Cavendish Street
    W1G 8UB London
    34
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector16613800002
    NAGGER, Jonathan
    34-43 Russell Street
    WC2B 5HA London
    Drury House
    Amministratore
    34-43 Russell Street
    WC2B 5HA London
    Drury House
    United KingdomBritishDirector151999890001
    PALMER, Steven Mark
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    Amministratore
    Nettlecombe Pyle Hill
    GU22 0SR Woking
    Surrey
    EnglandBritishDirector63240980001
    TAMBLYN, Nicholas
    Clouds Hill Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Clouds Hill Miles Lane
    KT11 2EF Cobham
    Surrey
    EnglandBritishManaging Director27144350003
    TURNER, Jane Elizabeth
    Flat 4 133 Sutherland Avenue
    Maida Vale
    W9 2QJ London
    Amministratore
    Flat 4 133 Sutherland Avenue
    Maida Vale
    W9 2QJ London
    EnglandBritishDirector123756290001
    WHITE, Madeleine
    Dolphin House Smugglers Way
    SW18 1DF London
    43
    United Kingdom
    Amministratore
    Dolphin House Smugglers Way
    SW18 1DF London
    43
    United Kingdom
    United KingdomNorwegianChartered Accountant134780580001
    WILLIAMS, Nicholas James
    13 Pelican Wharf
    58 Wapping Wall
    E1W 3SL London
    Amministratore
    13 Pelican Wharf
    58 Wapping Wall
    E1W 3SL London
    BritishDirector70374720007
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore delegato nominato
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RIGHTS LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    England
    06 apr 2016
    East Pallant
    PO19 1TR Chichester
    7
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09497136
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    RIGHTS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession and charge
    Creato il 02 mag 2012
    Consegnato il 17 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies and limited liability partnerships named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 mag 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second supplemental debenture
    Creato il 07 mag 2010
    Consegnato il 14 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Leveraged Loans Limited as Agent and Trustee for Itself and Each of the Beneficiaries (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 14 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creato il 10 ott 2008
    Consegnato il 24 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Leveraged Loans Limited (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 24 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 set 2006
    Consegnato il 20 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • G E Leveraged Loans Limited as Agent and Trustee for Itself and Each of the Beneficiaries(Security Agent)
    Transazioni
    • 20 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 lug 2006
    Consegnato il 02 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Leveraged Loans Limited (The Security Agent)
    • Ge Leveraged Loans Limited (The Security Agent)
    Transazioni
    • 02 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 24 mag 2006
    Consegnato il 08 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Leveraged Loans Limited
    Transazioni
    • 08 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 mag 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge in relation to intellectual property rights and related rights
    Creato il 28 mag 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all intellectual property rights in the works present and future and all licences present or future.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 lug 1998
    Consegnato il 11 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as hallco 215 limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0