COUNTRY THATCH INSURANCE AGENCY LIMITED

COUNTRY THATCH INSURANCE AGENCY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOUNTRY THATCH INSURANCE AGENCY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03555729
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COUNTRY THATCH INSURANCE AGENCY LIMITED?

    • (0111) /
    • (7499) /

    Dove si trova COUNTRY THATCH INSURANCE AGENCY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Towergate House Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COUNTRY THATCH INSURANCE AGENCY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per COUNTRY THATCH INSURANCE AGENCY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Andrew Hunter come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Samuel Thomas Budgen Clark come segretario

    1 pagineAP03

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 30 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mag 2011

    Stato del capitale al 19 mag 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Nomina di Mr Andrew Stewart Hunter come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Darryl Clark come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Nomina di Mr Darryl Clark come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy Craton come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 30 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Timothy Charles Craton il 30 apr 2010

    1 pagineCH03

    Cessazione della carica di Antony Proverbs come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di COUNTRY THATCH INSURANCE AGENCY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    161861590001
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Wealden Hall
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Wealden Hall
    Parkfield
    TN15 0HX Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish59873490009
    PHILIP, Timothy Duncan
    20 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    20 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish99066410001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    153022080001
    CRATON, Timothy Charles
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    British76055420004
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Segretario
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    156619070001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Segretario
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    British6180280001
    SMITH, Arthur James
    2 Barbel Road
    CO4 3EJ Colchester
    Essex
    Segretario
    2 Barbel Road
    CO4 3EJ Colchester
    Essex
    British44621220002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    CROCKER, Nicholas John David
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    Amministratore
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    British60697560014
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Amministratore
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    EnglandBritish99424380001
    PROVERBS, Antony
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    Amministratore
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    EnglandBritish79185700012
    RATCLIFF, Dennis George
    12 Green Lane
    Parsons Heath
    CO4 4JA Colchester
    Essex
    Amministratore
    12 Green Lane
    Parsons Heath
    CO4 4JA Colchester
    Essex
    EnglandBritish6477170002
    THURSTON, Nicholas Claud
    46 Reynards Copse
    Highwoods
    CO4 9UR Colchester
    Essex
    Amministratore
    46 Reynards Copse
    Highwoods
    CO4 9UR Colchester
    Essex
    British33060250002
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    COUNTRY THATCH INSURANCE AGENCY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 ago 2001
    Consegnato il 13 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (the agent), the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank, the hedging bank, the zero per cent lenders, the investors and to any of them on any account whatsoever including without limitation under any of the financing documents (all terms as defined)
    Brevi particolari
    (Other than f/h property k/a 317 woodham lane new haw t/no.SY350608 and the f/h land at the south west of scotland bridge road new haw t/no.SY536467 in each case so long as the same is charged by towergate chase parkinson limited to coutts & co). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0