FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED

FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03558925
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    84a High Street
    CM12 9BT Billericay
    Essex
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ACTIVE CARE (DOMICILIARY) LIMITED06 mag 199806 mag 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Nomina di Mr David John Loftus come amministratore in data 31 lug 2012

    2 pagineAP01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Ian James White come amministratore in data 31 lug 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Ian White come segretario in data 31 lug 2012

    1 pagineTM02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Ms Christine Cameron come amministratore in data 02 mar 2012

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 ott 2012 al 02 mar 2012

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Michael Davide come amministratore in data 02 mar 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Baldev Singh Ladhar come amministratore in data 02 mar 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Armajit Singh Ladhar come amministratore in data 02 mar 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Armajit Singh Ladhar come segretario in data 02 mar 2012

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Ian White come segretario in data 02 mar 2012

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Ian James White come amministratore in data 02 mar 2012

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 15-16 Stockholm Close Tyne Tunnel Trading Estate North Shields Tyne &Wear NE29 7SF in data 26 mar 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 giu 2011

    Stato del capitale al 21 giu 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 31 ott 2009

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Davide il 10 mag 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Baldev Singh Ladhar il 10 mag 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Armajit Singh Ladhar il 10 mag 2010

    2 pagineCH01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAMERON, Christine Isabel
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish167809310001
    LOFTUS, David John
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish34443080001
    DAVISON, Kevin
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British58542350001
    DAVISON, Robert Walter
    48 Kepier Chare
    NE40 4UR Crawcrook
    Tyne & Wear
    Segretario
    48 Kepier Chare
    NE40 4UR Crawcrook
    Tyne & Wear
    British58542470001
    LADHAR, Armajit Singh
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Indian82918910002
    WHITE, Ian
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    167830840001
    DMCS SECRETARIES LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Segretario nominato
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900006030001
    CAIN, Leslie
    3 Ainderby Road
    Throckley
    NE15 9DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    3 Ainderby Road
    Throckley
    NE15 9DQ Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British100933450001
    DAVIDE, Michael
    67 Links Avenue
    NE26 1TF Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    67 Links Avenue
    NE26 1TF Whitley Bay
    Tyne & Wear
    EnglandBritish108531230001
    DAVISON, Caroline
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British72942620001
    DAVISON, Kevin
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    5 Riversdale Close
    Millrace Park Blackhall Mill
    NE17 7LW Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British58542350001
    DAVISON, Robert Walter
    48 Kepier Chare
    NE40 4UR Crawcrook
    Tyne & Wear
    Amministratore
    48 Kepier Chare
    NE40 4UR Crawcrook
    Tyne & Wear
    British58542470001
    LADHAR, Armajit Singh
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandIndian82918910002
    LADHAR, Baldev Singh
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    103 The Avenue
    Wallsend
    NE28 6SD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish92390260001
    WHITE, Ian James
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    High Street
    CM12 9BT Billericay
    84a
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish133383410003
    DMCS DIRECTORS LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Amministratore delegato nominato
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900004430001

    FLEXIBLE SUPPORT OPTIONS (UK DOMICILIARY) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 12 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transazioni
    • 12 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 ago 2004
    Consegnato il 03 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 03 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 26 ago 2004
    Consegnato il 03 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land and buildings on the north east side of struthers road high spen t/no TY369642. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 03 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ott 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 ott 2000
    Consegnato il 11 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0