BEAM ESTATES LIMITED
Panoramica
Nome della società | BEAM ESTATES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Liquidazione |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03565454 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BEAM ESTATES LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova BEAM ESTATES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Suite 5 2nd Floor Bulman House Regent Centre NE3 3LS Newcastle Upon Tyne |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BEAM ESTATES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BRIDGE COURT CONSTRUCTION LIMITED | 18 mag 1998 | 18 mag 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BEAM ESTATES LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2023 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2023 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BEAM ESTATES LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 18 mag 2024 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 01 giu 2024 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 18 mag 2023 |
Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per BEAM ESTATES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 mar 2024 | 11 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Quayside House 110 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX England a Suite 5 2nd Floor Bulman House Regent Centre Newcastle upon Tyne NE3 3LS in data 28 mar 2023 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2022 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2021 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Lesley Ann Ilderton come amministratore in data 30 set 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Clare Ingle come amministratore in data 17 giu 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Notifica di George Percy come persona con controllo significativo il 29 gen 2021 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Notifica di James Granville Egerton come persona con controllo significativo il 29 gen 2021 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Notifica di Ralph Percy come persona con controllo significativo il 29 gen 2021 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Notifica di James Percy come persona con controllo significativo il 29 gen 2021 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Cessazione di Weylands Investments Ltd come persona con controllo significativo il 29 gen 2021 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione di G D Group Ltd come persona con controllo significativo il 29 gen 2021 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 035654540017 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 035654540019 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 035654540018 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 035654540020 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 035654540021 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2021 al 31 mar 2021 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Notifica di Weylands Investments Ltd come persona con controllo significativo il 29 gen 2021 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BEAM ESTATES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNES, Colin Leslie | Amministratore | Bulman House Regent Centre NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor | England | British | Town & Country Planner | 79430060001 | ||||
INGLE, Clare | Amministratore | Bulman House Regent Centre NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor | United Kingdom | British | Cfo | 284397790001 | ||||
WILSON, Roderick Charles St John | Amministratore | Bulman House Regent Centre NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor | England | British | Land Agent | 279282770001 | ||||
BATCHELOR, Richard | Segretario | Sunnycroft 81 Rydens Road KT12 3AN Walton On Thames Surrey | British | 88305450001 | ||||||
MCLOUGHLIN, Colin Anthony | Segretario | Lyon Road KT12 3PU Walton On Thames 16 Surrey England | British | 32745720002 | ||||||
MCLOUGHLIN, Colin Anthony | Segretario | 52 Woodlands Road KT6 6PY Surbiton Surrey | British | Director | 32745720002 | |||||
TURNER, Ian | Segretario | 17 Knowle Park KT11 3AB Cobham Surrey | British | 45971320001 | ||||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
ILDERTON, Lesley Ann | Amministratore | 110 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne Quayside House England | England | British | Group Financial Controller | 176859460003 | ||||
MCLOUGHLIN, Colin Anthony | Amministratore | Lyon Road KT12 3PU Walton On Thames 16 Surrey England | England | British | Company Director | 32745720002 | ||||
PRINGLE, Hugh Charles Denny | Amministratore | Holmbury Lane RH5 6NA Holmbury St Mary Ockham Farm House Surrey England | United Kingdom | British | Company Director | 24868540005 | ||||
TURNER, Gary | Amministratore | 17 Knowle Park KT11 3AB Cobham Surrey | British | Director | 54374640002 | |||||
TURNER, Ian | Amministratore | 17 Knowle Park KT11 3AB Cobham Surrey | British | Director | 45971320001 | |||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BEAM ESTATES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weylands Investments Ltd | 29 gen 2021 | 110 Quayside NE1 3DX Newcastle Upon Tyne Quayside House England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Lord James Percy | 29 gen 2021 | Bulman House Regent Centre NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Duke Of Northumberland Ralph Percy | 29 gen 2021 | Bulman House Regent Centre NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Marquis Of Stafford James Granville Egerton | 29 gen 2021 | Bulman House Regent Centre NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Earl George Percy | 29 gen 2021 | Bulman House Regent Centre NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Suite 5 2nd Floor | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
G D Group Ltd | 06 apr 2016 | High Street SL5 7HP Ascot The Courtyard Berkshire United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
BEAM ESTATES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 13 gen 2014 Consegnato il 14 gen 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 27 goodge street london t/no NGL729771. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 13 gen 2014 Consegnato il 14 gen 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 336 molesey road hersham surrey t/no's SY363130,SY138176,SY607265. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 13 gen 2014 Consegnato il 14 gen 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Land on the south side of 108 new haw road addlestone surrey t/no SY740703. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 13 gen 2014 Consegnato il 14 gen 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione 108 new haw road addlestone surrey t/no SY486489. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 13 gen 2014 Consegnato il 14 gen 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 09 feb 2011 Consegnato il 11 feb 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 108 new haw road and land on the south side of 108 new haw road addlestone surrey t/no's SY486489 and SY740703. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 25 ago 2009 Consegnato il 26 ago 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a land lying to the west of station road esher. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 13 gen 2009 Consegnato il 22 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 336 molesay road walton-on-thames hersham surrey t/nos. SY363130, SY138176 and SY607265 assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 13 gen 2009 Consegnato il 22 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land adjoining 15 lyon road hersham surrey t/no. SY249786 assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 13 gen 2009 Consegnato il 22 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 11 lyon road hersham surrey t/no. SY125365 assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 gen 2009 Consegnato il 22 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 02 ott 2006 Consegnato il 06 ott 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 16 lyon road hersham trading estate walton-on-thames t/n sy 142870. assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 29 set 2006 Consegnato il 18 ott 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 27 goodge street london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 16 dic 2005 Consegnato il 21 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The properties being 336 molesey road hersham surrey t/n SY363130, wester cottage molesey road walton on thames t/n SY138176, land lying to east of molesey road hersham surrey t/n SY607265,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 24 nov 2003 Consegnato il 29 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £300,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The former racal site, 15 lyon road, hersham trading estate, molesey road, walton on thames, surrey t/no. SY249786. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 mar 2003 Consegnato il 19 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 11 lyon road hersham trading estate molesey road walton on thames surrey. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge and floating charge | Creato il 06 apr 2001 Consegnato il 14 apr 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £588,000.00 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage all that f/h property k/a friary house, 15 colston street bristol t/n BL15495 by way of first floating charge all the assets property and undertaking of the borrower whatsoever and wheresoever both present and future including all the goodwill and uncalled capital for the time being. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 18 gen 2001 Consegnato il 20 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £200,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee set out in the terms of the legal charge | |
Brevi particolari 13 upper teddington road hampton wick richmond upon thames KT1 4DL. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 apr 2000 Consegnato il 19 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 78 blenheim park rd,croydon; t/no SY182281. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 02 feb 2000 Consegnato il 09 feb 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 49 graham road purley surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
BEAM ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0