BEAM ESTATES LIMITED

BEAM ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBEAM ESTATES LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03565454
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di BEAM ESTATES LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova BEAM ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite 5 2nd Floor Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BEAM ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRIDGE COURT CONSTRUCTION LIMITED18 mag 199818 mag 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di BEAM ESTATES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2023
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2023
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BEAM ESTATES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al18 mag 2024
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma01 giu 2024
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al18 mag 2023
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per BEAM ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 mar 2024

    11 pagineLIQ03

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Quayside House 110 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX England a Suite 5 2nd Floor Bulman House Regent Centre Newcastle upon Tyne NE3 3LS in data 28 mar 2023

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 mar 2023

    LRESSP

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2022

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2021

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Lesley Ann Ilderton come amministratore in data 30 set 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Clare Ingle come amministratore in data 17 giu 2021

    2 pagineAP01

    Notifica di George Percy come persona con controllo significativo il 29 gen 2021

    2 paginePSC01

    Notifica di James Granville Egerton come persona con controllo significativo il 29 gen 2021

    2 paginePSC01

    Notifica di Ralph Percy come persona con controllo significativo il 29 gen 2021

    2 paginePSC01

    Notifica di James Percy come persona con controllo significativo il 29 gen 2021

    2 paginePSC01

    Cessazione di Weylands Investments Ltd come persona con controllo significativo il 29 gen 2021

    1 paginePSC07

    Cessazione di G D Group Ltd come persona con controllo significativo il 29 gen 2021

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 035654540017 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 035654540019 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 035654540018 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 035654540020 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 035654540021 in pieno

    1 pagineMR04

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2021 al 31 mar 2021

    1 pagineAA01

    Notifica di Weylands Investments Ltd come persona con controllo significativo il 29 gen 2021

    2 paginePSC02

    Chi sono gli amministratori di BEAM ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARNES, Colin Leslie
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    Amministratore
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    EnglandBritishTown & Country Planner79430060001
    INGLE, Clare
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    Amministratore
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    United KingdomBritishCfo284397790001
    WILSON, Roderick Charles St John
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    Amministratore
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    EnglandBritishLand Agent279282770001
    BATCHELOR, Richard
    Sunnycroft
    81 Rydens Road
    KT12 3AN Walton On Thames
    Surrey
    Segretario
    Sunnycroft
    81 Rydens Road
    KT12 3AN Walton On Thames
    Surrey
    British88305450001
    MCLOUGHLIN, Colin Anthony
    Lyon Road
    KT12 3PU Walton On Thames
    16
    Surrey
    England
    Segretario
    Lyon Road
    KT12 3PU Walton On Thames
    16
    Surrey
    England
    British32745720002
    MCLOUGHLIN, Colin Anthony
    52 Woodlands Road
    KT6 6PY Surbiton
    Surrey
    Segretario
    52 Woodlands Road
    KT6 6PY Surbiton
    Surrey
    BritishDirector32745720002
    TURNER, Ian
    17 Knowle Park
    KT11 3AB Cobham
    Surrey
    Segretario
    17 Knowle Park
    KT11 3AB Cobham
    Surrey
    British45971320001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ILDERTON, Lesley Ann
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    England
    Amministratore
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    England
    EnglandBritishGroup Financial Controller176859460003
    MCLOUGHLIN, Colin Anthony
    Lyon Road
    KT12 3PU Walton On Thames
    16
    Surrey
    England
    Amministratore
    Lyon Road
    KT12 3PU Walton On Thames
    16
    Surrey
    England
    EnglandBritishCompany Director32745720002
    PRINGLE, Hugh Charles Denny
    Holmbury Lane
    RH5 6NA Holmbury St Mary
    Ockham Farm House
    Surrey
    England
    Amministratore
    Holmbury Lane
    RH5 6NA Holmbury St Mary
    Ockham Farm House
    Surrey
    England
    United KingdomBritishCompany Director24868540005
    TURNER, Gary
    17 Knowle Park
    KT11 3AB Cobham
    Surrey
    Amministratore
    17 Knowle Park
    KT11 3AB Cobham
    Surrey
    BritishDirector54374640002
    TURNER, Ian
    17 Knowle Park
    KT11 3AB Cobham
    Surrey
    Amministratore
    17 Knowle Park
    KT11 3AB Cobham
    Surrey
    BritishDirector45971320001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BEAM ESTATES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Weylands Investments Ltd
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    England
    29 gen 2021
    110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Quayside House
    England
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies (England And Wales)
    Numero di registrazione12871011
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Lord James Percy
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    29 gen 2021
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Duke Of Northumberland Ralph Percy
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    29 gen 2021
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Marquis Of Stafford James Granville Egerton
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    29 gen 2021
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Earl George Percy
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    29 gen 2021
    Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Suite 5 2nd Floor
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    G D Group Ltd
    High Street
    SL5 7HP Ascot
    The Courtyard
    Berkshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    High Street
    SL5 7HP Ascot
    The Courtyard
    Berkshire
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione06700555
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    BEAM ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 gen 2014
    Consegnato il 14 gen 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    27 goodge street london t/no NGL729771. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 14 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 gen 2014
    Consegnato il 14 gen 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    336 molesey road hersham surrey t/no's SY363130,SY138176,SY607265. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 14 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 gen 2014
    Consegnato il 14 gen 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land on the south side of 108 new haw road addlestone surrey t/no SY740703. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 14 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 gen 2014
    Consegnato il 14 gen 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    108 new haw road addlestone surrey t/no SY486489. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 14 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 gen 2014
    Consegnato il 14 gen 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transazioni
    • 14 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 feb 2011
    Consegnato il 11 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    108 new haw road and land on the south side of 108 new haw road addlestone surrey t/no's SY486489 and SY740703.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 11 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 2009
    Consegnato il 26 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land lying to the west of station road esher.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 2009
    Consegnato il 22 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    336 molesay road walton-on-thames hersham surrey t/nos. SY363130, SY138176 and SY607265 assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 2009
    Consegnato il 22 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land adjoining 15 lyon road hersham surrey t/no. SY249786 assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 2009
    Consegnato il 22 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    11 lyon road hersham surrey t/no. SY125365 assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 gen 2009
    Consegnato il 22 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 02 ott 2006
    Consegnato il 06 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    16 lyon road hersham trading estate walton-on-thames t/n sy 142870. assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 29 set 2006
    Consegnato il 18 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    27 goodge street london.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 16 dic 2005
    Consegnato il 21 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The properties being 336 molesey road hersham surrey t/n SY363130, wester cottage molesey road walton on thames t/n SY138176, land lying to east of molesey road hersham surrey t/n SY607265,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 nov 2003
    Consegnato il 29 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £300,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The former racal site, 15 lyon road, hersham trading estate, molesey road, walton on thames, surrey t/no. SY249786.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 mar 2003
    Consegnato il 19 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    11 lyon road hersham trading estate molesey road walton on thames surrey.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge and floating charge
    Creato il 06 apr 2001
    Consegnato il 14 apr 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £588,000.00 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all that f/h property k/a friary house, 15 colston street bristol t/n BL15495 by way of first floating charge all the assets property and undertaking of the borrower whatsoever and wheresoever both present and future including all the goodwill and uncalled capital for the time being. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transazioni
    • 14 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 gen 2001
    Consegnato il 20 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee set out in the terms of the legal charge
    Brevi particolari
    13 upper teddington road hampton wick richmond upon thames KT1 4DL.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 2000
    Consegnato il 19 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    78 blenheim park rd,croydon; t/no SY182281. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 27 mar 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 feb 2000
    Consegnato il 09 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    49 graham road purley surrey. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BEAM ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 mar 2023Inizio della liquidazione
    16 mar 2023Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Phillip Ross
    Suite 5, 2nd Floor Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    Suite 5, 2nd Floor Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Allan David Kelly
    Suite 5, 2nd Floor Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    Suite 5, 2nd Floor Bulman House
    Regent Centre
    NE3 3LS Newcastle Upon Tyne

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0