TRILLIUM PROPERTY LIMITED

TRILLIUM PROPERTY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRILLIUM PROPERTY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03565812
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRILLIUM PROPERTY LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova TRILLIUM PROPERTY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    140 London Wall
    London
    EC2Y 5DN
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRILLIUM PROPERTY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per TRILLIUM PROPERTY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 12 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mag 2013

    Stato del capitale al 14 mag 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2012

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Ernitia Ferguson come segretario in data 01 gen 2012

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di William Frost come segretario in data 01 gen 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Warren Persky il 18 ott 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 12 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Warren Persky il 01 mar 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per William Frost il 15 dic 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Warren Persky il 09 dic 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    28 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    14 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    16 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288c

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di TRILLIUM PROPERTY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FERGUSON, Ernitia
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    United Kingdom
    Segretario
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    United Kingdom
    163009510001
    PERSKY, Warren Ashley
    140 London Wall
    London
    EC2Y 5DN
    Amministratore
    140 London Wall
    London
    EC2Y 5DN
    United KingdomBritish108635640073
    TRILLIUM GROUP LIMITED
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    Amministratore
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    103653140001
    TRILLIUM HOLDINGS LIMITED
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    Amministratore
    London Wall
    EC2Y 5DN London
    140
    103653930002
    BINGLEY, Joan Hilary
    Eaton Farm
    Miles Lane
    KT11 2ED Cobham
    Surrey
    Segretario
    Eaton Farm
    Miles Lane
    KT11 2ED Cobham
    Surrey
    Irish1388610001
    CHANDE, Manish Jayantilal
    9 Chester Place
    Regents Park
    NW1 4NB London
    Segretario
    9 Chester Place
    Regents Park
    NW1 4NB London
    British83291490001
    DUCKWORTH, Mark David
    213 Tufnell Park Road
    Tufnell Park
    N7 0PX London
    Segretario
    213 Tufnell Park Road
    Tufnell Park
    N7 0PX London
    British65235670003
    DUDGEON, Peter Maxwell
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    Segretario
    41 Links Road
    KT17 3PP Epsom
    Surrey
    British14674480002
    FROST, William
    140 London Wall
    London
    EC2Y 5DN
    Segretario
    140 London Wall
    London
    EC2Y 5DN
    British134060040001
    BLAXLAND, Simon Thomas
    237 Rue Du Foubourg Saint Honore
    75008 Paris
    FOREIGN France
    Amministratore
    237 Rue Du Foubourg Saint Honore
    75008 Paris
    FOREIGN France
    British58254750001
    CHANDE, Manish Jayantilal
    9 Chester Place
    Regents Park
    NW1 4NB London
    Amministratore
    9 Chester Place
    Regents Park
    NW1 4NB London
    British83291490001
    ELLIS, Ian David
    Oak Lodge, Moor Road
    Great Tey
    CO6 1JJ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Oak Lodge, Moor Road
    Great Tey
    CO6 1JJ Colchester
    Essex
    EnglandBritish68191870001
    FRANCO, Jon Jacob
    Flat 10
    31 Collingham Road
    SW5 0NU London
    Amministratore
    Flat 10
    31 Collingham Road
    SW5 0NU London
    American64630220002
    FRIEDLOS, Nicholas Robert
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    Amministratore
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    EnglandBritish61183260002
    FROST, William
    Kenley Road
    SW19 3DU London
    77
    Amministratore
    Kenley Road
    SW19 3DU London
    77
    British134060040001
    GARMAN, James Robert
    Flat 5
    56 Lexham Gardens
    W8 5JA London
    Amministratore
    Flat 5
    56 Lexham Gardens
    W8 5JA London
    British68523620003
    GODDEN, David Roy
    20 Frensham Road
    GU9 8HE Farnham
    Surrey
    Amministratore
    20 Frensham Road
    GU9 8HE Farnham
    Surrey
    EnglandBritish1950780001
    GRIFFITHS OF FFORESTFACH, Brian, Lord
    19 Chester Square
    SW1W 9HS London
    Amministratore
    19 Chester Square
    SW1W 9HS London
    British42617760001
    HOLT, David Leslie Frank
    44 Osier Crescent
    Muswell Hill
    N10 1QW London
    Amministratore
    44 Osier Crescent
    Muswell Hill
    N10 1QW London
    British100070620001
    LOZIER JR, James
    3512 Crescent Avenue
    75205 Dallas
    Texas
    Usa
    Amministratore
    3512 Crescent Avenue
    75205 Dallas
    Texas
    Usa
    American59540870001
    MURAIDEKH, Eli Sean
    Flat 2 136 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    Amministratore
    Flat 2 136 Gloucester Terrace
    W2 6HR London
    United KingdomBritish56166870001
    MYERS, Martin Trevor
    Durham Place
    SW3 4ET London
    1
    Amministratore
    Durham Place
    SW3 4ET London
    1
    EnglandBritish35819830001
    SISKIND, Edward
    61 Ledbury Road
    W11 2AA London
    Amministratore
    61 Ledbury Road
    W11 2AA London
    American64411260001
    SWEENEY, Peter Charles
    The Warren 61 Leas Road
    CR6 9LP Warlingham
    Surrey
    Amministratore
    The Warren 61 Leas Road
    CR6 9LP Warlingham
    Surrey
    British30672780001
    WILSON, Gavin Edward Reid
    38 Upper Cheyne Row
    SW3 5JJ London
    Amministratore
    38 Upper Cheyne Row
    SW3 5JJ London
    British56166890001

    TRILLIUM PROPERTY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 19 nov 2009
    Consegnato il 26 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Eurohypo Ag London Branch
    Transazioni
    • 26 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Supplemental security agreement
    Creato il 07 giu 2004
    Consegnato il 21 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land k/a 96 wilmslow road manchester t/no LA104846 all buildings fixtures fittings fixed plant and machinery and the benefit of any covenants for title given in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 21 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 25 may 2004 and
    Creato il 06 mag 2004
    Consegnato il 08 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole those subjects k/a and forming 12-14 woodstock street, kilmarnock t/n:AYR049196.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 25 may 2004 and
    Creato il 06 mag 2004
    Consegnato il 08 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole those subjects k/a and forming block 5, caponacre industrial estate, cumnock t/n:AYR42597.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee
    Transazioni
    • 08 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 25 may 2004 and
    Creato il 06 mag 2004
    Consegnato il 08 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole those subjects to the east of emmock road, dundee t/n:ANG6938.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 06 mag 2004
    Consegnato il 19 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, contracts, intellectual property, goodwill and uncalled capital floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 19 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 01 ago 2000
    Consegnato il 09 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under each finance document and the hedging arrangements
    Brevi particolari
    All the mortgaged property together with all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale and the benefit of any covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Trustee for the Security Parties) (Theagent)
    Transazioni
    • 09 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 17 apr 2000
    Consegnato il 05 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document and the hedging arrangements (as defined)
    Brevi particolari
    F/Hold property known as beacon tower and lodge house,fishponds rd,bristol; t/no BL37316; all buildings/fixtures thereon and proceeds of sale thereof; the benefit of any covenants for title and any monys paid or payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Trustee for the Security Parties(As Defined)
    Transazioni
    • 05 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture
    Creato il 09 mar 2000
    Consegnato il 28 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from any chargor to the chargee under each finance document and the hedging arrangements
    Brevi particolari
    By way of a first legal mortgage the mortgaged property specified in the schedule of the deed together with all buildings and fixtures thereon, the proceeds of sales of all or any part thereof and the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title and any moneys paid or payable in respect of such covenants. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 lug 1999
    Consegnato il 16 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under each finance document and the hedging arrangements
    Brevi particolari
    All plant and machinery book and other debts goodwill and uncalled capital; by way of a first floating charge all its assets situated outwith scotland or governed otherwise than by scots law not otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage or charge or assignment.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Security Parties (The "Agent")
    Transazioni
    • 16 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0