IMAGELINX PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIMAGELINX PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03567041
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IMAGELINX PLC?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova IMAGELINX PLC?

    Indirizzo della sede legale
    New Bridge Street House
    30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IMAGELINX PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LTG TECHNOLOGIES PLC11 ago 199811 ago 1998
    BOOSTRETURN PUBLIC LIMITED COMPANY19 mag 199819 mag 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di IMAGELINX PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per IMAGELINX PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    18 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2017

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2016

    16 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2015

    16 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 45 Lilyville Road London SW6 5DP a New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street London EC4V 6BJ in data 17 set 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 set 2014

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 15 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 lug 2014

    Stato del capitale al 14 lug 2014

    • Capitale: GBP 289,038.635
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 15 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 set 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 set 2013

    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/0 Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park Lowmoor Road Kirkby in Ashfield Nottinghamshire NG17 5HN* in data 19 set 2013

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 8 in parte

    4 pagineMR04

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2012

    38 pagineAA

    Nomina di Mr Alistair Kynoch Rae come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Louise Palmer come segretario

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare un numero di azioni

    RES09
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Cessazione della carica di Ian Branagan come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Ian Branagan come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 giu 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Franz-Michael Wimpffen il 15 giu 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2011

    74 pagineAA

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2010

    88 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 15 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di IMAGELINX PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RAE, Alistair Kynoch
    Lilyville Road
    SW6 5DP London
    45
    England
    Segretario
    Lilyville Road
    SW6 5DP London
    45
    England
    180611260001
    CLOTHIER, Richard John
    30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    New Bridge Street House
    Amministratore
    30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    New Bridge Street House
    United KingdomBritishNone57893800005
    RAE, Alistair Kynoch
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    Amministratore
    45 Lilyville Road
    SW6 5DP London
    EnglandBritishCeo53806830002
    STRAKER SMITH, Richard David
    3 Berkeley Gardens
    W8 4AP London
    Amministratore
    3 Berkeley Gardens
    W8 4AP London
    United KingdomBritishStockbroker60595790001
    WIMPFFEN, Franz-Michael, Dr
    Munchingerstrasse 5
    Ditzingen
    D-71254
    Germany
    Amministratore
    Munchingerstrasse 5
    Ditzingen
    D-71254
    Germany
    GermanyAustrianDirector39617420001
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Segretario
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    GermanManager69193840001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Segretario
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    BritishFinancial Director94273950001
    PALMER, Louise
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    12 The Pinfold
    Glapwell
    S44 5PU Chesterfield
    Derbyshire
    British119011320002
    WILLIAMSON, Michael
    222 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LB London
    Segretario
    222 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LB London
    British90174630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    THROGMORTON SECRETARIES LIMITED
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    Segretario
    42 Portman Road
    RG30 1EA Reading
    Berkshire
    80839850001
    BANGE, Udo Karl
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    Amministratore
    28 Linden Gardens
    W2 4ES London
    GermanDirector69193840001
    BRANAGAN, Ian
    Park Vista
    Greenwich
    SE10 9LZ London
    26
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Vista
    Greenwich
    SE10 9LZ London
    26
    United Kingdom
    United KingdomIrishMarketing175184540001
    FISCHER, Thomas, Doctor
    Isolde-Kurz-Strasse 2
    FOREIGN Stuttgart D-70619
    Germany
    Amministratore
    Isolde-Kurz-Strasse 2
    FOREIGN Stuttgart D-70619
    Germany
    GermanDirector95923300001
    HEIZMANN, Peter, Dr
    Zwisslerstrasse 1
    Ludwigsburg D-71640
    Germany
    Amministratore
    Zwisslerstrasse 1
    Ludwigsburg D-71640
    Germany
    GermanCompany Director39617750002
    HOLMES, John Edwin
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    45 Linden Road Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9DP Newcastle Upon Tyne
    BritishRetired42461820001
    HUNTER, Nicholas James
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    Amministratore
    1031 Oxford Road
    RG31 6TL Reading
    Berkshire
    EnglandBritishFinancial Director94273950001
    KLEIN, Albert Kenngott
    C/0 Imagelinx Uk Ltd
    Julias Way Station Park
    NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    C/0 Imagelinx Uk Ltd
    Julias Way Station Park
    NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield
    Nottinghamshire
    GermanChairman69826640003
    OUSEY, Byron John
    3 Knights House
    Gainsford Street
    SE1 2NB London
    Amministratore
    3 Knights House
    Gainsford Street
    SE1 2NB London
    BritishManaging Director29835940001
    WEDELL, Gregor
    Angelikastrasse 11
    Dresden
    Saxony 01099
    Germany
    Amministratore
    Angelikastrasse 11
    Dresden
    Saxony 01099
    Germany
    GermanLawyer93874350001
    WILLIAMSON, Michael
    222 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LB London
    Amministratore
    222 Sheen Lane
    East Sheen
    SW14 8LB London
    BritishAccountant90174630001
    ZIEGENBEIN, Kristian Axel
    Flat 4
    16 Burdon Terrace
    NE2 3AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Flat 4
    16 Burdon Terrace
    NE2 3AE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    GermanManager67297990001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Amministratore delegato nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    IMAGELINX PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 30 lug 2009
    Consegnato il 04 ago 2009
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 04 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 2013Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    A share charge
    Creato il 18 lug 2008
    Consegnato il 24 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (the shareholder) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The shaerholder charges in favour of the chargee by way of first fixed charge all shares held by the shareholder and/or any nominee on its behalf and all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ltg Holding Gmbh & Co
    Transazioni
    • 24 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment
    Creato il 27 mar 2006
    Consegnato il 08 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right, title and interest in and to all the assigned rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landesbank Baden-Wurttemberg
    Transazioni
    • 08 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 01 mar 2006
    Consegnato il 14 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the securities and any proceeds of sale aring there from all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landesbank Baden-Wurttemberg
    Transazioni
    • 14 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 ago 2002
    Consegnato il 07 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 10 apr 2000
    Consegnato il 28 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to:(i) a facilities agreement dated 11 november 1998 (as defined);(ii) a facility agreement dated 5 april 2000 (as defined);(iii) any and all other mortgages,charges,pledges,guarantees and other instruments from time to time (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed charge over the shares in image linx international limited listed in schedule and proceeds of sale thereof; all dividends,credits,rebates or refunds thereon and all other offers,rights,moneys,securities and property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landesbank Baden - Wurttenburg
    Transazioni
    • 28 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 12 lug 1999
    Consegnato il 02 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys, obligations and liabilities from time to time due, owing or incurred to the chargee and the banks (as defined in the assignment) by the company under or pursuant to: (a) a facilities agreement dated 11TH november 1998 between ltg technologies PLC and ltg mailander gmbh as borrower and the assignee as lender (the "ltg loan agreement"); and (b) the assignment
    Brevi particolari
    All the present and future rights titles benefits and interests whether proprietary contractual or otherwise under or arising out of or evidenced by: (a) a loan agreement dated 31 july 1998 between industrial heat enterprises international corporation and ltg holding cmbh;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landesbank Baden-Wurttenberg
    Transazioni
    • 02 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of shares
    Creato il 12 lug 1999
    Consegnato il 02 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities from time to time due or to become due from the company to the chargee and the banks (as defined in the mortgage) (the "secured parties") under or pursuant to a facilities agreement dated 11TH november 1998 and the mortgage
    Brevi particolari
    The 20,282,849 ordinary shares of £1 each in crabtree group PLC (the "shares") by way of first legal mortgage and fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landesbank Baden-Wurttenburg
    Transazioni
    • 02 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    IMAGELINX PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 set 2014Inizio della liquidazione
    27 feb 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul M Davis
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Praticante
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Frederick Charles Satow
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London
    Praticante
    New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street
    EC4V 6BJ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0