IMAGELINX PLC
Panoramica
Nome della società | IMAGELINX PLC |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società per azioni |
Numero di società | 03567041 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IMAGELINX PLC?
- altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere
Dove si trova IMAGELINX PLC?
Indirizzo della sede legale | New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street EC4V 6BJ London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IMAGELINX PLC?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LTG TECHNOLOGIES PLC | 11 ago 1998 | 11 ago 1998 |
BOOSTRETURN PUBLIC LIMITED COMPANY | 19 mag 1998 | 19 mag 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IMAGELINX PLC?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2012 |
Quali sono le ultime deposizioni per IMAGELINX PLC?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 18 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2017 | 17 pagine | LIQ03 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2016 | 16 pagine | 4.68 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 set 2015 | 16 pagine | 4.68 | ||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 45 Lilyville Road London SW6 5DP a New Bridge Street House 30-34 New Bridge Street London EC4V 6BJ in data 17 set 2014 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * C/0 Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park Lowmoor Road Kirkby in Ashfield Nottinghamshire NG17 5HN* in data 19 set 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 8 in parte | 4 pagine | MR04 | ||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2012 | 38 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Alistair Kynoch Rae come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Louise Palmer come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Ian Branagan come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Ian Branagan come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 giu 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Franz-Michael Wimpffen il 15 giu 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2011 | 74 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2010 | 88 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 16 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di IMAGELINX PLC?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAE, Alistair Kynoch | Segretario | Lilyville Road SW6 5DP London 45 England | 180611260001 | |||||||
CLOTHIER, Richard John | Amministratore | 30-34 New Bridge Street EC4V 6BJ London New Bridge Street House | United Kingdom | British | None | 57893800005 | ||||
RAE, Alistair Kynoch | Amministratore | 45 Lilyville Road SW6 5DP London | England | British | Ceo | 53806830002 | ||||
STRAKER SMITH, Richard David | Amministratore | 3 Berkeley Gardens W8 4AP London | United Kingdom | British | Stockbroker | 60595790001 | ||||
WIMPFFEN, Franz-Michael, Dr | Amministratore | Munchingerstrasse 5 Ditzingen D-71254 Germany | Germany | Austrian | Director | 39617420001 | ||||
BANGE, Udo Karl | Segretario | 28 Linden Gardens W2 4ES London | German | Manager | 69193840001 | |||||
HUNTER, Nicholas James | Segretario | 1031 Oxford Road RG31 6TL Reading Berkshire | British | Financial Director | 94273950001 | |||||
PALMER, Louise | Segretario | 12 The Pinfold Glapwell S44 5PU Chesterfield Derbyshire | British | 119011320002 | ||||||
WILLIAMSON, Michael | Segretario | 222 Sheen Lane East Sheen SW14 8LB London | British | 90174630001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
THROGMORTON SECRETARIES LIMITED | Segretario | 42 Portman Road RG30 1EA Reading Berkshire | 80839850001 | |||||||
BANGE, Udo Karl | Amministratore | 28 Linden Gardens W2 4ES London | German | Director | 69193840001 | |||||
BRANAGAN, Ian | Amministratore | Park Vista Greenwich SE10 9LZ London 26 United Kingdom | United Kingdom | Irish | Marketing | 175184540001 | ||||
FISCHER, Thomas, Doctor | Amministratore | Isolde-Kurz-Strasse 2 FOREIGN Stuttgart D-70619 Germany | German | Director | 95923300001 | |||||
HEIZMANN, Peter, Dr | Amministratore | Zwisslerstrasse 1 Ludwigsburg D-71640 Germany | German | Company Director | 39617750002 | |||||
HOLMES, John Edwin | Amministratore | 45 Linden Road Darras Hall Ponteland NE20 9DP Newcastle Upon Tyne | British | Retired | 42461820001 | |||||
HUNTER, Nicholas James | Amministratore | 1031 Oxford Road RG31 6TL Reading Berkshire | England | British | Financial Director | 94273950001 | ||||
KLEIN, Albert Kenngott | Amministratore | C/0 Imagelinx Uk Ltd Julias Way Station Park NG17 5HN Lowmoor Road Kirkby In Ashfield Nottinghamshire | German | Chairman | 69826640003 | |||||
OUSEY, Byron John | Amministratore | 3 Knights House Gainsford Street SE1 2NB London | British | Managing Director | 29835940001 | |||||
WEDELL, Gregor | Amministratore | Angelikastrasse 11 Dresden Saxony 01099 Germany | German | Lawyer | 93874350001 | |||||
WILLIAMSON, Michael | Amministratore | 222 Sheen Lane East Sheen SW14 8LB London | British | Accountant | 90174630001 | |||||
ZIEGENBEIN, Kristian Axel | Amministratore | Flat 4 16 Burdon Terrace NE2 3AE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | German | Manager | 67297990001 | |||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 |
IMAGELINX PLC ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
All assets debenture | Creato il 30 lug 2009 Consegnato il 04 ago 2009 | Parzialmente soddisfatta | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A share charge | Creato il 18 lug 2008 Consegnato il 24 lug 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company (the shareholder) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The shaerholder charges in favour of the chargee by way of first fixed charge all shares held by the shareholder and/or any nominee on its behalf and all related rights see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment | Creato il 27 mar 2006 Consegnato il 08 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Right, title and interest in and to all the assigned rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over shares | Creato il 01 mar 2006 Consegnato il 14 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge the securities and any proceeds of sale aring there from all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 06 ago 2002 Consegnato il 07 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over shares | Creato il 10 apr 2000 Consegnato il 28 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to:(i) a facilities agreement dated 11 november 1998 (as defined);(ii) a facility agreement dated 5 april 2000 (as defined);(iii) any and all other mortgages,charges,pledges,guarantees and other instruments from time to time (as defined) | |
Brevi particolari Fixed charge over the shares in image linx international limited listed in schedule and proceeds of sale thereof; all dividends,credits,rebates or refunds thereon and all other offers,rights,moneys,securities and property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment | Creato il 12 lug 1999 Consegnato il 02 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys, obligations and liabilities from time to time due, owing or incurred to the chargee and the banks (as defined in the assignment) by the company under or pursuant to: (a) a facilities agreement dated 11TH november 1998 between ltg technologies PLC and ltg mailander gmbh as borrower and the assignee as lender (the "ltg loan agreement"); and (b) the assignment | |
Brevi particolari All the present and future rights titles benefits and interests whether proprietary contractual or otherwise under or arising out of or evidenced by: (a) a loan agreement dated 31 july 1998 between industrial heat enterprises international corporation and ltg holding cmbh;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage of shares | Creato il 12 lug 1999 Consegnato il 02 ago 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies obligations and liabilities from time to time due or to become due from the company to the chargee and the banks (as defined in the mortgage) (the "secured parties") under or pursuant to a facilities agreement dated 11TH november 1998 and the mortgage | |
Brevi particolari The 20,282,849 ordinary shares of £1 each in crabtree group PLC (the "shares") by way of first legal mortgage and fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
IMAGELINX PLC ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0