HOTEL DU VIN (BRISTOL) LIMITED

HOTEL DU VIN (BRISTOL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHOTEL DU VIN (BRISTOL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03569323
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HOTEL DU VIN (BRISTOL) LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova HOTEL DU VIN (BRISTOL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Appold Street
    EC2A 2HB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HOTEL DU VIN (BRISTOL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STEELRAY NO. 119 LIMITED22 mag 199822 mag 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di HOTEL DU VIN (BRISTOL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per HOTEL DU VIN (BRISTOL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2016 al 30 set 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 gen 2016

    Stato del capitale al 19 gen 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Wfw Legal Services Limited come segretario in data 17 giu 2015

    2 pagineAP04

    Indirizzo della sede legale modificato da One Fleet Place London EC4M 7WS a 15 Appold Street London EC2A 2HB in data 22 giu 2015

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 035693230005 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Gary Reginald Davis come amministratore in data 17 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata One Fleet Place London EC4M 7WS

    1 pagineAD04

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account reduced by £2319999 19/12/2014
    RES13

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 035693230005

    5 pagineMR05

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 11 giu 2014

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 11 giu 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 mag 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Chi sono gli amministratori di HOTEL DU VIN (BRISTOL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WFW LEGAL SERVICES LIMITED
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    Segretario
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione1648390
    18093320001
    ROBERTS, Paul
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    Amministratore
    Appold Street
    EC2A 2HB London
    15
    England
    United KingdomBritish168184220001
    BLURTON, Andrew Francis
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    Segretario
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    British53724380001
    CHITTICK, Peter Harrison
    24 St Thomas Street
    SO23 9HJ Winchester
    Hampshire
    Segretario
    24 St Thomas Street
    SO23 9HJ Winchester
    Hampshire
    Canadian71873640002
    HUTSON, Robin Charles
    The Beeches
    7 Christchurch Road
    SO23 9SR Winchester
    Hampshire
    Segretario
    The Beeches
    7 Christchurch Road
    SO23 9SR Winchester
    Hampshire
    British49633060002
    KINGE, Andrew Alan
    88 Downlands Way
    South Wonston
    SO21 3HS Winchester
    Hampshire
    Segretario
    88 Downlands Way
    South Wonston
    SO21 3HS Winchester
    Hampshire
    British51750880001
    ROBSON, Gail
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    British100895090001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Segretario
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    STEELRAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Vandale House
    Post Office Road
    BH1 1BX Bournemouth
    Segretario nominato
    Vandale House
    Post Office Road
    BH1 1BX Bournemouth
    900001190001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Amministratore
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BASSET, Gerard Francis Claude
    6 Woodlawn Close
    Barton On Sea
    BH25 7BY New Milton
    Hampshire
    Amministratore
    6 Woodlawn Close
    Barton On Sea
    BH25 7BY New Milton
    Hampshire
    EnglandFrench84217310001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLURTON, Andrew Francis
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish53724380001
    CHITTICK, Peter Harrison
    24 St Thomas Street
    SO23 9HJ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    24 St Thomas Street
    SO23 9HJ Winchester
    Hampshire
    United KingdomCanadian71873640002
    COOK, Robert Barclay
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    Amministratore
    Longhoughton Road
    Lesbury
    NE66 3AT Alnwick
    Dukes Ryde
    Northumberland
    United KingdomBritish136758210001
    DAVIS, Gary Reginald
    Fleet Place
    EC4M 7WS London
    One
    England
    Amministratore
    Fleet Place
    EC4M 7WS London
    One
    England
    EnglandBritish167510270002
    ELLIOT, Colin David
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5LS London
    179
    England
    EnglandBritish154267590001
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Amministratore
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    HUTSON, Robin Charles
    The Beeches
    7 Christchurch Road
    SO23 9SR Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    The Beeches
    7 Christchurch Road
    SO23 9SR Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish49633060002
    MORGAN, Charles Maxwell
    36 Icknield Way
    HP23 4HZ Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    36 Icknield Way
    HP23 4HZ Tring
    Hertfordshire
    British65599970001
    NIDDRIE, Robert Charles
    Morestead House
    Morestead
    SO21 1LZ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Morestead House
    Morestead
    SO21 1LZ Winchester
    Hampshire
    British18525510001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Amministratore
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SINGH, Jagtar
    West Garden Place
    W2 2AQ London
    1
    England
    Amministratore
    West Garden Place
    W2 2AQ London
    1
    England
    United KingdomBritish121710890001
    STEELE RAYMOND LIMITED
    Vandale House
    Post Office Road
    BH1 1BX Bournemouth
    Dorset
    Amministratore delegato nominato
    Vandale House
    Post Office Road
    BH1 1BX Bournemouth
    Dorset
    900009070001

    HOTEL DU VIN (BRISTOL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 apr 2014
    Consegnato il 11 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The f/h land under t/no BL60428 and k/a hotel du vin bristol the sugarhouse lewins mead bristol.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 11 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 nov 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 22 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 feb 2008
    Consegnato il 14 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Original Lenders and the Agent) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 14 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 ott 2004
    Consegnato il 19 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each company to each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 19 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 ott 2004
    Consegnato il 09 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors, or any of them to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a birmingham hotel 25 church street birmingham t/no WM719621, f/h property k/a brighton hotel 4-6 ship street brighton t/no ESX99486, f/h property k/a bristol hotel A.sugar house lewins mead bristol BL60428. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 lug 1999
    Consegnato il 11 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0