ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED
Panoramica
Nome della società | ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03570205 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CHURCHCROFT VCT LIMITED | 17 giu 1998 | 17 giu 1998 |
PINCO 1068 LIMITED | 26 mag 1998 | 26 mag 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione | 6 pagine | 1.4 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore | 4 pagine | 1.1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 mag 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 mag 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 7 pagine | MG01 | ||||||||||
Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Mcleish come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 26 mag 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2009 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Smith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR, Stephen Jonathan | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 163496070001 | ||||
DAVIS, William Edward | Segretario | Beechcroft Wield Road GU34 5NH Medstead Alton Hampshire | British | 4522990001 | ||||||
GAIN, Jonathan Mark | Segretario | 9 Nash Place HP10 8ES Penn Buckinghamshire | British | 47508930005 | ||||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158304430001 | |||||||
MCLEISH, William David | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
SCOTT, Philip Henry | Segretario | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | British | Director | 174231320001 | |||||
PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds | 900013300001 | |||||||
BETTUM, Ole | Amministratore | 54 Primrose Gardens NW3 4TP London | England | Norwegian | Banker | 50551730002 | ||||
BOLOT, Timothy James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 107837080002 | ||||
BUCHAN, William James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 79917240001 | ||||
BURGESS, Richard John | Amministratore | 54 Manor Road SM2 7AG Cheam Surrey | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | British | Accountant | 35427700001 | ||||
COLVIN, William | Amministratore | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890003 | ||||
FARMER, Nicholas John | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 124228290001 | ||||
FOULKES, Kamma | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 111188390002 | ||||
FRYER, Martin | Amministratore | The Dell Bungalow Cats Lane CO10 6SF Sudbury Suffolk | British | Nurse | 72517560002 | |||||
LOCK, Jason David | Amministratore | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | Director | 144822040001 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 110640170001 | ||||
MURPHY, John | Amministratore | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | Director | 26177180004 | ||||
MURRAY, Andrew John | Amministratore | 10 Rosgill Drive Middleton M24 4SQ Manchester Lancashire | British | Managing Director | 110957990001 | |||||
ROBINSON, Anthony Leake | Amministratore | The Rose Garden Orchehill Avenue SL9 8QE Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Director | 48323880002 | |||||
ROGERS, Michael Greig | Amministratore | 1 Jenningsbury Court London Road SG13 7NS Hertford Hertfordshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 107156650001 | ||||
RUTTER, Christopher | Amministratore | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Director | 103588940001 | |||||
SCOTT, Philip Henry | Amministratore | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | Director | 174231320001 | ||||
SIZER, Graham Kevin | Amministratore | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | Director | 77274540003 | ||||
SMITH, David Andrew, Mr. | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
SMITH, David Andrew, Mr. | Amministratore | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | 41 Park Square LS1 2NS Leeds | 900013290001 |
ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Supplemental legal mortgage | Creato il 06 mag 2011 Consegnato il 20 mag 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Churchfields residential home avenue road witham t/no EX748144 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 29 feb 2008 Consegnato il 14 mar 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 06 giu 2007 Consegnato il 19 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 07 lug 2006 Consegnato il 20 lug 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 apr 2005 Consegnato il 15 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 set 2004 Consegnato il 28 set 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 apr 2004 Consegnato il 11 mag 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 dic 1999 Consegnato il 06 gen 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan stock deed | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 23 giu 1998 Consegnato il 09 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan stock deed of even date | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0