AXIS (RUGBY) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAXIS (RUGBY) LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03573327
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AXIS (RUGBY) LTD?

    • Centri di fitness (93130) / Attività artistiche, sportive e di divertimento

    Dove si trova AXIS (RUGBY) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di AXIS (RUGBY) LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per AXIS (RUGBY) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Pure Gym Limited Town Centre House Leeds LS2 8LY United Kingdom a 15 Canada Square London E14 5GL in data 28 feb 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 06 feb 2018

    LRESSP

    Cessazione della carica di Peter William Denby Roberts come amministratore in data 30 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jacques De Bruin come amministratore in data 30 nov 2017

    1 pagineTM01

    Notifica di L a Fitness Limited come persona con controllo significativo il 01 ago 2017

    2 paginePSC02

    Cessazione di Axis Health & Fitness Limited come persona con controllo significativo il 01 ago 2017

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 giu 2016

    Stato del capitale al 03 giu 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 ott 2015 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall Doncaster South Yorkshire DN3 1QR a C/O Pure Gym Limited Town Centre House Leeds LS2 8LY in data 06 nov 2015

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 035733270011 in pieno

    4 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter William Denby Roberts il 08 ott 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ott 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 giu 2015

    Stato del capitale al 15 giu 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Nomina di Mr Adam John Gordon Bellamy come segretario in data 28 mag 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Ross Steven Chester come amministratore in data 28 mag 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di AXIS (RUGBY) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Segretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    198433690001
    BELLAMY, Adam John Gordon
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishDirector172693720002
    COBBOLD, Humphrey Michael
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomBritishDirector100141010001
    DAVIES, Raymond Alan
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    Segretario
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    BritishCompany Director4878250001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    BritishChief Financial Officer124301460001
    JARVIS, Diane
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    Segretario
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    BritishFinance Director79818790001
    STEELE, Ronald Frank
    Middle Halings
    Halings Lane Denham
    UB9 5DQ Uxbridge
    Middlesex
    Segretario
    Middle Halings
    Halings Lane Denham
    UB9 5DQ Uxbridge
    Middlesex
    British42597630001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Segretario
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    BritishFinance Director114849640001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Segretario
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    BritishFinance Director114849640001
    TAYLOR, Graham
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    Segretario
    14 Roupell Street
    SE1 8SP London
    British82374420004
    TAYLOR, Richard
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    Segretario
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    BritishDirector71126560002
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BROSTER, Stuart Paul
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    Amministratore
    Greystones Bromley Road
    Cockleford Heath Ardleigh
    CO7 7SE Colchester
    Essex
    United KingdomBritishDirector114847350001
    BRUIN, Jacques De
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Town Centre House
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    United KingdomSouth AfricanDirector198346420001
    CHESTER, Ross Steven
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    BritishDirector137527310001
    DAVIES, Raymond Alan
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    Amministratore
    1 Woburn Close
    GU16 8NU Frimley
    Surrey
    BritishCompany Director4878250001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer124301460001
    GREALEY, Martyn
    Rowington House Pound Close
    Off Poolhead Lane
    B94 5ET Earlswood
    Warwickshire
    Amministratore
    Rowington House Pound Close
    Off Poolhead Lane
    B94 5ET Earlswood
    Warwickshire
    United KingdomBritishManaging Director125401590001
    JARVIS, Diane
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    Amministratore
    Tudor Cottage
    Ranks Green
    CM3 2BG Fairstead
    Essex
    EnglandBritishFinance Director79818790001
    LEWIS, Stephen Clifton
    2 Pinewood Close
    SL9 7DS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Pinewood Close
    SL9 7DS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector34392890004
    LONG, Martin
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector125885350001
    MCCOLL, Arthur
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    C/O La Fitness Limited
    Sandall Stones Road Kirk Sandall
    DN3 1QR Doncaster
    South Yorkshire
    AustraliaBritishDirector139099550001
    PHILPOTT, Stephen John Randall
    St John's Cottage
    Cherry Tree Lane
    SL3 6JE Fulmer
    Berkshire
    Amministratore
    St John's Cottage
    Cherry Tree Lane
    SL3 6JE Fulmer
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director45243130001
    PURSLOW, Christian Mark Cecil
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    Amministratore
    The Grove
    Warren Park Coombe Hill
    KT2 7HX Kingston Upon Thames
    United KingdomBritishDirector83244210001
    ROBERTS, Peter William Denby
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    The Hutts
    United Kingdom
    Amministratore
    Hutts Lane, Grewelthorpe
    HG4 3DA Ripon
    The Hutts
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector106538510001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector114849640001
    STORR, Christopher James
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    The Grange
    Hollingdon
    DE6 3GB Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritishFinance Director114849640001
    TAYLOR, Lisa
    4 Priory Road
    Chiswick
    W4 5JB London
    Amministratore
    4 Priory Road
    Chiswick
    W4 5JB London
    BritishCompany Director94657960001
    TAYLOR, Richard
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    33 Green Lane
    HA8 7PS Edgware
    Middlesex
    BritishDirector71126560002
    TREHARNE, John Robert
    Forsdyke House Rocky Lane
    RH16 4RN Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Forsdyke House Rocky Lane
    RH16 4RN Haywards Heath
    West Sussex
    BritishCompany Director53953950001
    TUROK, Frederick Oliver
    1 Broome Hall
    RH5 6HJ Cold Harbour
    Surrey
    Amministratore
    1 Broome Hall
    RH5 6HJ Cold Harbour
    Surrey
    EnglandSouth AfricanDirector41174400002
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di AXIS (RUGBY) LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    01 ago 2017
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03224406
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Town Centre House
    Merrion Centre
    LS2 8LY Leeds
    C/O Pure Gym Limited
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02802122
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    AXIS (RUGBY) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 05 giu 2014
    Consegnato il 10 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental security and confirmation deed
    Creato il 30 ago 2011
    Consegnato il 13 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and all monies due or to become due from the chargors to all or any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its relevant assets as more specifically referred to in the relevant security documents upon the terms contained in the relevant security documents. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Amendment deed
    Creato il 21 lug 2009
    Consegnato il 31 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The remaining assets, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Various Lenders (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 21 giu 2006
    Consegnato il 03 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H dragons health club webb ellis road rugby t/no WK293062.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 03 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 23 mar 2006
    Consegnato il 03 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the crunch finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Its interest in the land referred to opposite its name in schedule 1 meaning, dragons health club, webb ellis road, rugby t/no WK293062. For details of further land charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 03 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 20 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 mar 2006
    Consegnato il 03 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 03 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture
    Creato il 26 apr 2002
    Consegnato il 09 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies,liabilities and obligations whatsoever due or to become due by any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including (I) the f/hold property known as northwood squash club,chestnut ave,northwood,midd'x; AGL37538; (ii) f/hold property known as broke hill golf club,sevenoaks road,halstead sevenoaks; K588424 and K685755; (iii) l/hold property known as broke hill golf club,sevenoaks rd,halstead,sevenoaks; K725693; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 ott 2001
    Consegnato il 19 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H webb ellis road rugby warwickshire t/n-WK293062.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ott 2001
    Consegnato il 17 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 25 nov 1999
    Consegnato il 08 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 lug 1998
    Consegnato il 05 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H webb ellis road bilton rugby t/n-WK293062.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    AXIS (RUGBY) LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 apr 2019Data di scioglimento
    06 feb 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0