AVANTI AWS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAVANTI AWS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03573561
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AVANTI AWS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova AVANTI AWS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Indigo House
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AVANTI AWS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CREDENTIAL AWS LIMITED26 mar 200726 mar 2007
    WASTE TYRE SOLUTIONS LIMITED02 giu 199802 giu 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di AVANTI AWS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per AVANTI AWS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 mar 2018

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di John Paul Johnston come amministratore in data 01 ott 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert John Guice come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Paul James Kinley come amministratore in data 31 gen 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 giu 2016

    Stato del capitale al 10 giu 2016

    • Capitale: GBP 30,001
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    2 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 giu 2015

    Stato del capitale al 26 giu 2015

    • Capitale: GBP 30,001
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    20 pagineAA

    Nomina di Mr John Paul Johnston come amministratore in data 05 dic 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Fredrick Clesen come amministratore in data 05 dic 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 lug 2014

    Stato del capitale al 01 lug 2014

    • Capitale: GBP 30,001
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di AVANTI AWS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUICE, Robert John
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United KingdomBritish203379250001
    BONOMY, Robert George
    3 High Green
    DL5 4RZ Newton Aycliffe
    County Durham
    Segretario
    3 High Green
    DL5 4RZ Newton Aycliffe
    County Durham
    British8662500001
    CHEESEBROUGH, William Graham
    9 Shaftesbury Avenue
    LS8 1DR Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    9 Shaftesbury Avenue
    LS8 1DR Leeds
    West Yorkshire
    British79568320001
    COOPER, Alastair
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    British75329850001
    JORDAN, Michael
    Azahara, 69 Calle Ballesteros
    Urb. San Roque Club, 11360 San Roque
    LE10 0FT Cadiz
    Spain 11360
    Segretario
    Azahara, 69 Calle Ballesteros
    Urb. San Roque Club, 11360 San Roque
    LE10 0FT Cadiz
    Spain 11360
    British42732170006
    LLOYD, David Alan
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    British151028320001
    LOVELL, Richard Andrew
    Cherry Tree Cottage
    Kimbolton
    HR6 0HQ Leominster
    Herefordshire
    Segretario
    Cherry Tree Cottage
    Kimbolton
    HR6 0HQ Leominster
    Herefordshire
    British69197490001
    PORTER, Derek
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    Segretario
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    British47585310001
    RAPID COMPANY SERVICES LIMITED
    81a Corbets Tey Road
    RM14 2AJ Upminster
    Essex
    Segretario nominato
    81a Corbets Tey Road
    RM14 2AJ Upminster
    Essex
    900012130001
    BAVAIRD, David Wilson
    66 Linskill Terrace
    Tynemouth
    NE30 2EP North Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    66 Linskill Terrace
    Tynemouth
    NE30 2EP North Shields
    Tyne & Wear
    EnglandBritish123673180001
    BONOMY, Robert George
    3 High Green
    DL5 4RZ Newton Aycliffe
    County Durham
    Amministratore
    3 High Green
    DL5 4RZ Newton Aycliffe
    County Durham
    British8662500001
    BRYAN, Ian Peter
    23 Hillingdon Avenue
    Lodge Park
    NG16 1RA Nuthall
    Nottinghamshire
    Amministratore
    23 Hillingdon Avenue
    Lodge Park
    NG16 1RA Nuthall
    Nottinghamshire
    British79005380001
    CHEESEBROUGH, William Graham
    9 Shaftesbury Avenue
    LS8 1DR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    9 Shaftesbury Avenue
    LS8 1DR Leeds
    West Yorkshire
    British79568320001
    CLAPHAM, Ronald Barrie
    Flat 8/2, 12 Lancefield Quay
    G3 8HR Glasgow
    Amministratore
    Flat 8/2, 12 Lancefield Quay
    G3 8HR Glasgow
    ScotlandBritish101562830001
    CLESEN, John Fredrick
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    UsaAmerican156396820001
    COOPER, Alastair
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish75329850001
    FISHWICK, Michael
    3 Dalton Lane
    Burton
    LA6 1NG Carnforth
    Lancashire
    Amministratore
    3 Dalton Lane
    Burton
    LA6 1NG Carnforth
    Lancashire
    British107989450001
    GIBSON, Graham
    94 Castle Green
    Westbrook
    WA5 7XA Warrington
    Amministratore
    94 Castle Green
    Westbrook
    WA5 7XA Warrington
    British68365490003
    HINTON, Andrew Peter, Mr.
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish114646030002
    JOHNSTON, John Paul
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    IrelandIrish165352310001
    JOHNSTON, John Paul
    London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd Floor Apex House
    Kent
    Amministratore
    London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd Floor Apex House
    Kent
    IrelandIrish162398480001
    JORDAN, Michael
    Azahara, 69 Calle Ballesteros
    Urb. San Roque Club, 11360 San Roque
    LE10 0FT Cadiz
    Spain 11360
    Amministratore
    Azahara, 69 Calle Ballesteros
    Urb. San Roque Club, 11360 San Roque
    LE10 0FT Cadiz
    Spain 11360
    British42732170006
    KINLEY, Paul James
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish43914170002
    LLOYD, David Alan
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish155636220001
    MCIVER, Alan Mark, Mr.
    London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd Floor Apex House
    Kent
    Amministratore
    London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd Floor Apex House
    Kent
    EnglandBritish90738630002
    OLIVER, Gary James
    West House
    DH7 8ST Brandon Village
    County Durham
    Amministratore
    West House
    DH7 8ST Brandon Village
    County Durham
    British34355000004
    PATTERSON, Stephen
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish188301290001
    PATTERSON, Stephen
    1 Abbey Farm Cottages
    Manfield
    DL2 2RE Darlington
    County Durham
    Amministratore
    1 Abbey Farm Cottages
    Manfield
    DL2 2RE Darlington
    County Durham
    United KingdomBritish188301290001
    PORTER, Derek
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    Amministratore
    Mayfield
    Tandlehill Road
    PA10 2DD Kilbarchan
    Renfrewshire
    United KingdomBritish47585310001
    SIMPSON, Paul
    London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd Floor Apex House
    Kent
    Amministratore
    London Road
    DA11 9PD Northfleet
    2nd Floor Apex House
    Kent
    EnglandBritish155636280001
    TEMPLEMAN, Rodney Mark
    The Coach House
    Hurstwood Lane
    TN4 8YA Royal Tunbridge Wells
    Amministratore
    The Coach House
    Hurstwood Lane
    TN4 8YA Royal Tunbridge Wells
    British79976450002
    TRANTER, Mavis Beryl
    Yew Tree Cottage
    Stapleton
    LD8 2LS Presteigne
    Powys
    Amministratore
    Yew Tree Cottage
    Stapleton
    LD8 2LS Presteigne
    Powys
    British43797550001
    WHITTLE, Kevin Richardson
    West House 14 Brandon Village
    Brandon
    DH7 8ST Durham
    County Durham
    Amministratore
    West House 14 Brandon Village
    Brandon
    DH7 8ST Durham
    County Durham
    British50763670001
    WYATT, Nicholas Andrew
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Harewood Yard
    Harewood
    LS17 9LF Leeds
    Unit 1a
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish73704370001
    RAPID NOMINEES LIMITED
    81a Corbets Tey Road
    RM14 2AJ Upminster
    Essex
    Amministratore delegato nominato
    81a Corbets Tey Road
    RM14 2AJ Upminster
    Essex
    900012120001

    Chi sono le persone con controllo significativo di AVANTI AWS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Sussex Avenue
    LS10 2LF Leeds
    Indigo House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3226910
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    AVANTI AWS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus set-off agreement
    Creato il 11 gen 2012
    Consegnato il 12 gen 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies with the bank whether such accounts are in the sole name of any of the companies or in the joint names of two or more of the companies including any accounts in the bank's name with any designation which includes the name(s) of any one or more of the companies, whether such accounts be denominated in sterling or any other currency.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 ott 2008
    Consegnato il 31 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the debtor or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Hinton
    Transazioni
    • 31 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 ott 2008
    Consegnato il 31 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the debtor or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nicholas Wyatt
    Transazioni
    • 31 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 21 ott 2008
    Consegnato il 24 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 02 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and ce holdings limited to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bridges Community Ventures Limited (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 02 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 30 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or credential environmental limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Martin Gibson
    Transazioni
    • 30 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 30 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or credential environmental limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Hinton
    Transazioni
    • 30 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 30 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or credential environmental limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trustees of the Andrew Peter Hinton 2001 Accumulation and Maintenance Settlement
    Transazioni
    • 30 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 30 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or credential environmental limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ian Bryan
    Transazioni
    • 30 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 30 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or credential environmental limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nicholas Wyatt
    Transazioni
    • 30 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 05 lug 2007
    Consegnato il 11 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 nov 2006
    Consegnato il 23 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 17 nov 2006
    Consegnato il 23 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as waste tyre solutions limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Performance bond
    Creato il 19 set 2003
    Consegnato il 26 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £32,832.00 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    £32,832.00.
    Persone aventi diritto
    • Clarnor Estates Limited
    Transazioni
    • 26 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 dic 2001
    Consegnato il 07 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 nov 1998
    Consegnato il 05 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the financing documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 05 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0