SANTON RETAIL LIMITED

SANTON RETAIL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSANTON RETAIL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03575203
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SANTON RETAIL LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova SANTON RETAIL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Santon House 53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SANTON RETAIL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RAVEN RETAIL LIMITED10 apr 200210 apr 2002
    RAVEN SOHO LIMITED29 mag 199829 mag 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di SANTON RETAIL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per SANTON RETAIL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2022

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Vincent John Donnelly come amministratore in data 19 ott 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2021

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Bimaljit Singh Sandhu il 01 mar 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Vincent John Donnelly il 01 mar 2019

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    12 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2017 al 31 mar 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 apr 2016

    14 pagineAA

    Nomina di Mr Ravi Shirishkumar Patel come segretario in data 31 ago 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Sean Carey come segretario in data 31 ago 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Sean Carey come amministratore in data 31 ago 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Ravi Shirishkumar Patel come amministratore in data 31 ago 2016

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SANTON RETAIL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PATEL, Ravi Shirishkumar
    53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Santon House
    Segretario
    53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Santon House
    213363760001
    PATEL, Ravi Shirishkumar
    53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Santon House
    Amministratore
    53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Santon House
    EnglandBritish199318230001
    SANDHU, Bimaljit Singh, Mr.
    53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Santon House
    Amministratore
    53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Santon House
    EnglandBritish35609600002
    SANTON CLOSE NOMINEES LIMITED
    53-55 Uxbridge Road
    W5 5SA Ealing
    Santon House
    London
    England
    Amministratore
    53-55 Uxbridge Road
    W5 5SA Ealing
    Santon House
    London
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazioneSC135168
    84319870004
    CAREY, Sean
    Kingsbury
    Cresta Drive, Woodham
    KT15 3SW Addlestone
    Surrey
    Segretario
    Kingsbury
    Cresta Drive, Woodham
    KT15 3SW Addlestone
    Surrey
    British103661680002
    KENNEDY, Rachel
    2 Dunollie Place
    NW5 2XR London
    Segretario
    2 Dunollie Place
    NW5 2XR London
    British81155350003
    MOBBERLEY, Andrew George
    44 Wilmot Way
    SM7 2PY Banstead
    Surrey
    Segretario
    44 Wilmot Way
    SM7 2PY Banstead
    Surrey
    British71501390003
    PATEL, Himakshu
    37 Ferndown
    HA6 1PH Northwood
    Middlesex
    Segretario
    37 Ferndown
    HA6 1PH Northwood
    Middlesex
    British42175710003
    PATEL, Ravi
    Bishop Ramsey Close
    HA4 8GY Ruislip
    4
    Middlesex
    United Kingdom
    Segretario
    Bishop Ramsey Close
    HA4 8GY Ruislip
    4
    Middlesex
    United Kingdom
    Other140892050001
    PEREIRA, Alan Dennis
    Gallinar
    Pilgrims Close
    RH5 6AR Westhumble
    Surrey
    Segretario
    Gallinar
    Pilgrims Close
    RH5 6AR Westhumble
    Surrey
    British61856670006
    SANDHU, Bimaljit Singh, Mr.
    56 Grange Road
    Ealing
    W5 5BX London
    Segretario
    56 Grange Road
    Ealing
    W5 5BX London
    British35609600002
    FINANCIAL AND LEGAL SERVICES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01884202
    63025870004
    L.C.I. SECRETARIES LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    Segretario
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    51349360001
    BILTON, Anton John Godfrey
    46 Cadogan Place
    SW1X 9RU London
    Amministratore
    46 Cadogan Place
    SW1X 9RU London
    British21454000001
    BILTON, Laurence James
    2 Hotham Hall
    Hotham Road Putney
    SW15 1QS London
    Amministratore
    2 Hotham Hall
    Hotham Road Putney
    SW15 1QS London
    British67947250002
    CAREY, Sean
    Kingsbury
    Cresta Drive, Woodham
    KT15 3SW Addlestone
    Surrey
    Amministratore
    Kingsbury
    Cresta Drive, Woodham
    KT15 3SW Addlestone
    Surrey
    United KingdomBritish103661680002
    DONNELLY, Vincent John
    53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Santon House
    Amministratore
    53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Santon House
    EnglandBritish127214310001
    MOBBERLEY, Andrew George
    34 Wolseley Avenue
    SW19 8BQ London
    Amministratore
    34 Wolseley Avenue
    SW19 8BQ London
    British71501390002
    SANDHU, Bimaljit Singh, Mr.
    56 Grange Road
    Ealing
    W5 5BX London
    Amministratore
    56 Grange Road
    Ealing
    W5 5BX London
    EnglandBritish35609600002
    L.C.I. DIRECTORS LIMITED
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    Amministratore
    60 Tabernacle Street
    EC2A 4NB London
    47946060001
    RAVEN MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    First Floor
    21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    Amministratore
    First Floor
    21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    84584390001
    RAVEN PROPERTY HOLDINGS PLC
    Swan Court Waterman's Business
    Park Kingsbury Crescent
    TW18 3BA Staines
    Middlesex
    Amministratore
    Swan Court Waterman's Business
    Park Kingsbury Crescent
    TW18 3BA Staines
    Middlesex
    106024710001
    SANTON CLOSE NOMINEES LIMITED
    First Floor
    21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    Amministratore
    First Floor
    21 Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    84319870004

    Chi sono le persone con controllo significativo di SANTON RETAIL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr. Bimaljit Singh Sandhu
    53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Santon House
    11 mag 2017
    53/55 Uxbridge Road
    Ealing
    W5 5SA London
    Santon House
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SANTON RETAIL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation in security dated 13 january and intimation
    Creato il 22 gen 2009
    Consegnato il 23 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to any other secured party
    Brevi particolari
    All right title and interest under the specified contracts relating to a development at stobcross, arbroath including the right to any payments thereunder.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Benefit of All Secured Parties)
    Transazioni
    • 23 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignation of rents dated 13 january and intimation
    Creato il 22 gen 2009
    Consegnato il 23 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to any other secured party
    Brevi particolari
    All rental income under a lease of property at stobcross arbroath between the company (as landlord) and tesco stores limited (as tenant).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Benefit of All Secured Parties)
    Transazioni
    • 23 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 27 nov 2008
    Consegnato il 31 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole two areas of ground at stobcross and robert street, arbroath t/no ANG22894.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 21 nov 2008
    Consegnato il 04 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h land on the east side of sheffield road whittington moor newbold chesterfield t/no DY87520 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 04 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 01 ott 2008
    Consegnato il 03 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The additional property - land at ellesmere wharf, ellesmere, shropshire being part of the land under t/no SL178188.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited (Tesco)
    Transazioni
    • 03 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 29 set 2008
    Consegnato il 25 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The area of ground extending to 2.451 hectares or thereby lying to the western side of grampian road aviemore see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 25 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 29 set 2008
    Consegnato il 25 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The area of ground extending to 2.451 hectares or thereby lying to the western side of grampian road aviemore see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Property Holdings Limited
    Transazioni
    • 25 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 29 set 2008
    Consegnato il 30 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Interest in a lease of subjects at west shaw street, kilmarnock t/no AYR84661.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Property Holdings Limited
    Transazioni
    • 30 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 29 set 2008
    Consegnato il 30 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Interest in a lease of subjects at west shaw street kilmarnock t/no AYR84661.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 30 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 29 set 2008
    Consegnato il 24 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subjects at ormlie road thurso t/no CTH588.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 25 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 29 set 2008
    Consegnato il 24 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subjects at chapel street tain TOS5800.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 29 set 2008
    Consegnato il 24 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subjects at stobcross and robert street arbroath t/no ANG22894.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 11 set 2008
    Consegnato il 24 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subjects at ormlie road thurso CTH588.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Property Holdings Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 25 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 11 set 2008
    Consegnato il 24 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subjects at chapel street tain t/no ROS5800.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Property Holdings Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 11 set 2008
    Consegnato il 24 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Stobcross and robert street arbroath t/no ANG22894.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Property Holdings Limited
    Transazioni
    • 24 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 11 set 2008
    Consegnato il 02 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interests in any permitted property, all plant and machinery, rental income, disposal proceeds see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Santon Developments PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 11 set 2008
    Consegnato il 25 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interests in any permitted property, all plant and a=machinery, rental income, disposal proceeds see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wetsre Hailes Shopping Centre Limited
    Transazioni
    • 25 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 set 2008
    Consegnato il 19 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including uncalled capital, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited (Tesco)
    Transazioni
    • 19 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security document
    Creato il 11 set 2008
    Consegnato il 19 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 19 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2008
    • 31 mar 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 05 set 2008
    Consegnato il 17 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subjects at chapel street tain t/no ROS5800.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Property Holdings Limited
    Transazioni
    • 17 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 lug 2008
    Consegnato il 01 ago 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that land at leek road and bucknall road hanley stoke on trent t/no SF93746 all buildings fixtures and fixed plant and machinery and other structures see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 01 ago 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 mag 2008
    Consegnato il 06 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All land at ellesmere wharf, ellsmere, shropshire t/n SL178188 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 06 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 apr 2008
    Consegnato il 11 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that land at cookworthy road kingsbridge devon t/nos DN178444 and DN562157; including any land, all buildings, fixtures and fixed plant and machinery and other structures now or in the future on it. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 11 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security
    Creato il 28 mar 2008
    Consegnato il 12 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects at ormlie road, thurso t/no. CTH588.
    Persone aventi diritto
    • Miller Developments Limited
    Transazioni
    • 12 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 19 mar 2008
    Consegnato il 24 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subjects at ormlie road thurso t/no CTH588.
    Persone aventi diritto
    • Tesco Stores Limited
    Transazioni
    • 24 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0