SAMUELSON COMMUNICATIONS LIMITED
Panoramica
Nome della società | SAMUELSON COMMUNICATIONS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03576148 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SAMUELSON COMMUNICATIONS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova SAMUELSON COMMUNICATIONS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Paul Mckenna Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SAMUELSON COMMUNICATIONS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HACKREMCO (NO.1359) LIMITED | 05 giu 1998 | 05 giu 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SAMUELSON COMMUNICATIONS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SAMUELSON COMMUNICATIONS LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per SAMUELSON COMMUNICATIONS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Ashok Makanji come segretario in data 15 dic 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Steven Moster come amministratore in data 03 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Brian Dykstra come amministratore in data 03 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Mckenna come segretario in data 15 dic 2014 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 100 Centennial Avenue Elstree Hertfordshire WD6 3SA a C/O Paul Mckenna Silverstone Drive Gallagher Business Park Coventry CV6 6PA in data 15 dic 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Ashok Makanji come segretario in data 16 set 2014 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Nicholas John Marshall come amministratore in data 16 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ellen Marie Ingersoll come amministratore in data 16 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Paul Brian Dykstra come amministratore in data 16 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ashok Makanji come segretario in data 16 set 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Munir Akberali Samji come amministratore in data 16 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ashok Makanji come amministratore in data 16 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SAMUELSON COMMUNICATIONS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKENNA, Paul | Segretario | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | 193461780001 | |||||||
INGERSOLL, Ellen Marie | Amministratore | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | United States | American | Director | 118864140001 | ||||
MARSHALL, Nicholas John | Amministratore | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | England | British | Director | 20708530004 | ||||
MOSTER, Steven | Amministratore | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | United States | American | Chairman, President And Ceo Of Viad Corp | 193607710001 | ||||
COOK, Russell John | Segretario | 26 Egmont Road KT6 7AT Surbiton Surrey | British | 64676640001 | ||||||
DAVIES, Digby John | Segretario | 1a Cambridge Road TW1 2HN Twickenham Middlesex | British | Company Secretary/Director | 38937270002 | |||||
DAY, Christopher Alexander Coryton | Segretario | 48 Whitley Court Road Quinton B32 1EY Birmingham West Midlands | British | Group Financial Controller | 92047820001 | |||||
GORDON, Neil Arthur | Segretario | Stable Cottage, Burrows Lea Hook Lane, Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | British | Company Director | 73989530001 | |||||
MAKANJI, Ashok | Segretario | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | 191998770001 | |||||||
MAKANJI, Ashok | Segretario | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | British | Director | 120367360001 | |||||
PATEL, Daxshaben | Segretario | 2 Millers Court Vicars Bridge Close HA0 1XG Alperton Middlesex | British | 96045520001 | ||||||
WAKELEY, David Peacefull | Segretario | 166 Rosemary Hill Road B74 4HN Sutton Coldfield West Midlands | British | 86839080001 | ||||||
HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||
BEDDOW, Charles Edward Kenneth | Amministratore | Manor Road MK45 4NU Barton Le Clay 163 Bedfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 132281430001 | ||||
BREEN, Michael John | Amministratore | 47 Wieland Road HA6 3QX Northwood Middlesex | England | English | Accountant | 8442840002 | ||||
DAVIES, Digby John | Amministratore | 1a Cambridge Road TW1 2HN Twickenham Middlesex | British | Company Secretary/Director | 38937270002 | |||||
DAY, Barry David | Amministratore | The Old Rectory Hatton Green Hatton CV35 7LA Warwick Warwickshire | England | British | Company Director | 57937960001 | ||||
DYKSTRA, Paul Brian | Amministratore | Silverstone Drive Gallagher Business Park CV6 6PA Coventry C/O Paul Mckenna England | Usa | American | Director | 118864330001 | ||||
ELLIS, Robert Keith | Amministratore | 55 Bushy Park Road TW11 9DQ Teddington Middlesex | England | British | Company Director | 45171010001 | ||||
GORDON, Neil Arthur | Amministratore | Stable Cottage, Burrows Lea Hook Lane, Shere GU5 9QQ Guildford Surrey | England | British | Company Director | 73989530001 | ||||
MAKANJI, Ashok | Amministratore | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 120367360001 | ||||
MARSHALL, Nicholas John | Amministratore | Spring House Fieldgate Lawn, Fieldgate Lane CV8 1BT Kenilworth Warwickshire | England | British | Company Director | 20708530004 | ||||
SAMJI, Munir Akberali | Amministratore | Unit 100 Centennial Avenue WD6 3SA Elstree Hertfordshire | United Kingdom | United Kingdom | Company Director | 119498620001 | ||||
WATTS, Michael | Amministratore | Bottle Lane SL6 3SB Littlewick Green Bay Tree Cottage Berks | British | Finance Director | 133568510001 | |||||
HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
SAMUELSON COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture between (1) the chargor (the company) and (2) national westminster bank PLC (the security trustee) as agent and trustee for the secured parties (as defined) | Creato il 08 mag 2000 Consegnato il 16 mag 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the chargor to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the financing documents (as defined) including the debenture | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 30 lug 1998 Consegnato il 11 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to all or any of the financing documents including the guarantee and debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0