PHIP (6) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPHIP (6) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03580448
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PHIP (6) LIMITED?

    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova PHIP (6) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5th Floor Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PHIP (6) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHARTER MEDINVEST LIMITED26 apr 200226 apr 2002
    CHARTERED CONTRACTORS (N.W.) LIMITED12 giu 199812 giu 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di PHIP (6) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PHIP (6) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PHIP (6) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 07 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ott 2014

    Stato del capitale al 08 ott 2014

    • Capitale: GBP 99
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 22 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy David Walker-Arnott il 22 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Abraham Hyman il 22 lug 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Nexus Management Services Limited come segretario in data 01 mag 2014

    3 pagineAP04

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor Ryder Court 14 Ryder Street London SW1Y 6QB in data 07 mag 2014

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Margaret Helen Vaughan come amministratore in data 30 apr 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di J O Hambro Capital Management Limited come segretario in data 30 apr 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 12 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    10 pagineMG01

    Memorandum e Statuto

    27 pagineMEM/ARTS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di James Daryl Hambro come amministratore in data 26 ott 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Philip John Holland come amministratore in data 17 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 12 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PHIP (6) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Segretario
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4187765
    57253330002
    HOLLAND, Philip John
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant163838050001
    HYMAN, Harry Abraham
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    Amministratore
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    EnglandBritishChartered Accountant35560380005
    WALKER-ARNOTT, Timothy David
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    Amministratore
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    EnglandBritishChartered Surveyor131266520002
    HIND, David Ronald, Mr.
    Heathercroft 2 Caldy Chase Drive
    Caldy
    CH48 2LD Wirral
    Merseyside
    Segretario
    Heathercroft 2 Caldy Chase Drive
    Caldy
    CH48 2LD Wirral
    Merseyside
    British9174760001
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    Segretario
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2176004
    149904530001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    FITZMAURICE, Dermot
    Wisteria Cottage
    Chestnut Lane
    WA6 6XW Frodsham
    Cheshire
    Amministratore
    Wisteria Cottage
    Chestnut Lane
    WA6 6XW Frodsham
    Cheshire
    EnglandBritishDirector42953530004
    HAMBRO, James Daryl
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    Amministratore
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    United KingdomBritishCompany Director53684400001
    HIND, David Ronald, Mr.
    Heathercroft 2 Caldy Chase Drive
    Caldy
    CH48 2LD Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    Heathercroft 2 Caldy Chase Drive
    Caldy
    CH48 2LD Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritishCompany Secretary9174760001
    RATCLIFFE, Steven James
    Halewood House Farm
    Hollow Lane
    WA6 8ET Kingsley
    Cheshire
    Amministratore
    Halewood House Farm
    Hollow Lane
    WA6 8ET Kingsley
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector16018670003
    VAUGHAN, Margaret Helen
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    Amministratore
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    United KingdomBritishChartered Accountant123167120001

    PHIP (6) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 apr 2012
    Consegnato il 04 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery, land and accounts. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2010
    Consegnato il 16 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land on the east and west sides of henry street leigh t/nos GM677377 and GM930817; by way of fixed charge all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, vehicles, computer equipment, tools and other chattels. The goodwill of any business carried on at the property, all rents receivable from any lease granted out of the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 10 giu 2010
    Consegnato il 16 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land on the east and west sides of henry street leigh t/nos GM677377 and GM930817; all plant and machinery, all insurance policies, all rental income. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Creato il 10 giu 2010
    Consegnato il 16 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transazioni
    • 16 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of agreement for lease
    Creato il 21 apr 2006
    Consegnato il 26 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    An agreement dated 21 april 2006.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 26 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 12 mag 2004
    Consegnato il 14 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the westerly and easterly sides of henry street leigh t/n GM677377. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 27 nov 2003
    Consegnato il 05 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a the ground floor office at hillview 63 main street frodsham. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 2003
    Consegnato il 01 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leigh health park henry street leigh greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 apr 2003
    Consegnato il 23 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 01 ago 2001
    Consegnato il 03 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    25A ullet road liverpool and 11 aighburgh road liverpool. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0