PAYPOINT PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPAYPOINT PLC
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03581541
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di PAYPOINT PLC?

    • Altre attività di servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione (62090) / Informazione e comunicazione
    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PAYPOINT PLC?

    Indirizzo della sede legale
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PAYPOINT PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PAYPOINT LIMITED04 ago 199804 ago 1998
    LEADHOLD LIMITED15 giu 199815 giu 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di PAYPOINT PLC?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PAYPOINT PLC?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al21 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma05 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al21 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per PAYPOINT PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 11 mar 2025

    • Capitale: GBP 236,511.94
    4 pagineSH06

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    07 mar 2025Clarification HMRC confirmation received appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    10 mar 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 04 mar 2025

    • Capitale: GBP 236,714.44
    4 pagineSH06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 27 feb 2025

    • Capitale: GBP 236,924.1
    3 pagineSH01

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 25 feb 2025

    • Capitale: GBP 236,915.29
    4 pagineSH06

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 18 feb 2025

    • Capitale: GBP 237,113.53
    4 pagineSH06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 feb 2025

    • Capitale: GBP 237,122.68
    3 pagineSH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 17 feb 2025

    • Capitale: GBP 237,311.65
    3 pagineSH01

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    17 feb 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 11 feb 2025

    • Capitale: GBP 237,298.47
    4 pagineSH06

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 29 gen 2025

    • Capitale: GBP 237,687.32
    4 pagineSH06

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 05 feb 2025

    • Capitale: GBP 237,496.25
    4 pagineSH06

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    05 feb 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    05 feb 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    05 feb 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    27 gen 2025Clarification HMRC confirmation received appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 21 gen 2025

    • Capitale: GBP 237,861.24
    4 pagineSH06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 gen 2025

    • Capitale: GBP 237,865.87
    3 pagineSH01

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 14 gen 2025

    • Capitale: GBP 238,038.78
    4 pagineSH06

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    13 gen 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    13 gen 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 08 gen 2025

    • Capitale: GBP 238,204.28
    4 pagineSH06

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    07 gen 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Acquisto di azioni proprie.

    4 pagineSH03
    Note
    DataNota
    06 gen 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Chi sono gli amministratori di PAYPOINT PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INDIGO CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh-On-Sea
    Monometer House
    England
    Segretario
    Rectory Grove
    SS9 2HL Leigh-On-Sea
    Monometer House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione13253973
    281695990002
    HARDING, David Robert
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant269895420001
    KERR, Giles Francis Bertram
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector202849490001
    SHAPLAND, Rosemary Jean
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director275037160001
    SHARMA, Rakesh
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector253839580001
    TU, Thi Nhuoc Lan
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritishNon-Executive Director163940470001
    WILES, Nicholas Winston Braid
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritishNone141641510001
    WISHART, Ben
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    NetherlandsBritishChief Information Officer264569390001
    CARNE, Sarah
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    1 The Boulevard
    Herts
    United Kingdom
    Segretario
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    1 The Boulevard
    Herts
    United Kingdom
    265358220001
    CLIFFORD, Amanda Elizabeth
    5 Lambrook Terrace
    Fulham
    SW6 6TF London
    Segretario
    5 Lambrook Terrace
    Fulham
    SW6 6TF London
    BritishTrainee Solicitor59910080001
    COURT, Susan Catherine
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British76828040003
    HANSON, Shay Dinata
    29 Trebovir Road
    SW5 9NQ London
    Segretario
    29 Trebovir Road
    SW5 9NQ London
    British64503850001
    MCDOUGALL, Ian Paul, Mr.
    39 Manor Road
    Old Moulsham
    CM2 0EP Chelmsford
    Essex
    Segretario
    39 Manor Road
    Old Moulsham
    CM2 0EP Chelmsford
    Essex
    BritishLegal Advisor68817460002
    MCLELLAND, Brian
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    292611670001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Segretario nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    ANSTEE, Eric Edward
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector76479900003
    ASTBURY, Mark Harvey Ayrton
    6 Blinco Grove
    CB1 7TS Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    6 Blinco Grove
    CB1 7TS Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishDirector101313750001
    BARR, Gillian Carole
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector165091810001
    BOTT, Stephen John
    Acorns
    The Fairway Busbridge
    GU7 1PG Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Acorns
    The Fairway Busbridge
    GU7 1PG Godalming
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Manager31624930002
    BULL, Ian Alan
    16 Wykeham Gate
    HP17 8DF Haddenham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    16 Wykeham Gate
    HP17 8DF Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director210299090001
    CARSON, Neil Andrew Patrick
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishChief Executive65525870003
    CLIFFORD, Amanda Elizabeth
    5 Lambrook Terrace
    Fulham
    SW6 6TF London
    Amministratore
    5 Lambrook Terrace
    Fulham
    SW6 6TF London
    BritishTrainee Solicitor59910080001
    COLLISON, David
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    Amministratore
    44 Lowther Road
    SW13 9NU London
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant34835160001
    DALE, Alan Christopher
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant96401190004
    EARLE, George William Eric David
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant8826580001
    HEADON, Patrick Vincent
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector257074890001
    KENTLETON, Rachel Elizabeth
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector287255940001
    MINTON, Kenneth Joseph
    7 Midway
    AL3 4BD St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Midway
    AL3 4BD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director513690001
    MORRISON, David John
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishInvestment Manager29500910005
    MURPHY, William Patrick
    Summerhaze Farm Church Street
    Woolley
    BA1 8AS Bath
    Amministratore
    Summerhaze Farm Church Street
    Woolley
    BA1 8AS Bath
    Great BritainRetiredCompany Director1612940005
    NEWLANDS, David Baxter
    Lane End Chucks Lane
    Walton-On-The-Hill
    KT20 7UB Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    Lane End Chucks Lane
    Walton-On-The-Hill
    KT20 7UB Tadworth
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director14918650001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector136891930001
    PAULL, Charles Arthur
    The Croft
    Station Road Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    The Croft
    Station Road Tilbrook
    PE28 0JT Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishAccountant654450001
    ROBB, Andrew Mackenzie
    16 Hillgate Place
    W8 7SJ London
    Amministratore
    16 Hillgate Place
    W8 7SJ London
    EnglandBritishDirector119518980001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 The Boulevard
    Shire Park
    AL7 1EL Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector93738770001

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0