OPENPSL HOLDINGS LIMITED

OPENPSL HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOPENPSL HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03591250
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OPENPSL HOLDINGS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova OPENPSL HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD
    The Capitol Building
    Oldbury
    RG12 8FZ Bracknell
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OPENPSL HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PREMIUM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED21 ago 199821 ago 1998
    BROOMCO (1608) LIMITED01 lug 199801 lug 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di OPENPSL HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 lug 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per OPENPSL HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Memorandum e Statuto

    9 pagineMA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 ago 2018

    • Capitale: GBP 7,185,084.1381
    8 pagineSH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 24 ago 2018

    • Capitale: GBP 0.0001
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 23/08/2018
    RES13

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Conto per una società dormiente redatto al 01 lug 2017

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Graeme Alistair Watt come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michael Ryan Mccoy come amministratore in data 27 feb 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 lug 2016

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 giu 2016

    Stato del capitale al 22 giu 2016

    • Capitale: GBP 84.1381
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 giu 2015

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Beate Reimann come amministratore in data 08 set 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Timothy Giles Willies come amministratore in data 08 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Beate Reimann come amministratore in data 08 set 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 giu 2015

    Stato del capitale al 12 giu 2015

    • Capitale: GBP 84.1381
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Beate Reimann il 01 nov 2014

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 giu 2014

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 the Sterling Centre Eastern Road Bracknell Berkshire RG12 2PW a C/O Avnet Technology Solutions Ltd the Capitol Building Oldbury Bracknell Berkshire RG12 8FZ in data 14 ott 2014

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di OPENPSL HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIES, Timothy Giles
    c/o Avnet Europe - Legal Department
    Kouterveldstraat
    B-1831 Diegem
    20
    Belgium
    Amministratore
    c/o Avnet Europe - Legal Department
    Kouterveldstraat
    B-1831 Diegem
    20
    Belgium
    EnglandBritishCfo Emea200807420001
    DUKE, Margaret Elizabeth
    53 Henley Avenue
    Thornhill
    WF12 0LN Dewsbury
    West Yorkshire
    Segretario
    53 Henley Avenue
    Thornhill
    WF12 0LN Dewsbury
    West Yorkshire
    BritishAccountant44370510002
    KONTOWTT, Michael Stefan
    21 Pendleside Close
    Sabden
    BB7 9DJ Clitheroe
    Lancashire
    Segretario
    21 Pendleside Close
    Sabden
    BB7 9DJ Clitheroe
    Lancashire
    BritishCompany Director60572810001
    LEE, Nicholas James
    Cox Lane
    Chessington
    KT9 1SJ Surrey
    Segretario
    Cox Lane
    Chessington
    KT9 1SJ Surrey
    BritishDirector65430060002
    LI, Jun
    Legal Department Avnet Europe Comm. V.A
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Segretario
    Legal Department Avnet Europe Comm. V.A
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    153745770001
    MACAULAY, Roderick Bruce
    Langland
    Huby
    LS17 0EG Leeds
    North Yorkshire
    Segretario
    Langland
    Huby
    LS17 0EG Leeds
    North Yorkshire
    British61322370001
    SCOTT, Victoria Selina
    39 The Spinnings
    BL9 5QW Summerseat
    Bury
    Segretario
    39 The Spinnings
    BL9 5QW Summerseat
    Bury
    BritishAccountant63251700001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    ARMITAGE, Peter Robert
    Coach House
    Sycamore Lane Springwood Road
    HD7 2SJ Holmfirth
    West Yorkshire
    Amministratore
    Coach House
    Sycamore Lane Springwood Road
    HD7 2SJ Holmfirth
    West Yorkshire
    BritishEquity Fund Manager107266580001
    BIRK, David Ralph, Mr.
    Legal Department Avnet Europe Comm. V.A.
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Amministratore
    Legal Department Avnet Europe Comm. V.A.
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    UsaAmericanDirector136282980001
    BLANEY, Martin Robert Charles
    Montpellier House
    Templewood Park Templewood Lane
    SL2 4DA Stoke Poges
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Montpellier House
    Templewood Park Templewood Lane
    SL2 4DA Stoke Poges
    Buckinghamshire
    BritishDirector96133290001
    CRAWSHAW, John Melvin
    89 Ramsgreave Drive
    BB1 8NA Blackburn
    Amministratore
    89 Ramsgreave Drive
    BB1 8NA Blackburn
    BritishCompany Director60385400001
    DIEU, Eric
    Legal Department Avnet Europe Comm. V.A.
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Amministratore
    Legal Department Avnet Europe Comm. V.A.
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    BelgiumBelgianDirector153745750001
    DUKE, Margaret Elizabeth
    Cox Lane
    Chessington
    KT9 1SJ Surrey
    Amministratore
    Cox Lane
    Chessington
    KT9 1SJ Surrey
    United KingdomBritishAccountant44370510002
    ELLIS, Jonathan
    Phoenix Lodge
    29a Sandmoor Drive
    LS17 7DF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Phoenix Lodge
    29a Sandmoor Drive
    LS17 7DF Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director111922590001
    FROOD, Thomas
    12 Gilbert Road
    Hale
    WA15 9NR Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    12 Gilbert Road
    Hale
    WA15 9NR Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director60572950003
    ILLSON, James Elias
    30 Mela Lane
    Rancho Palos Verde
    California 90275
    Usa
    Amministratore
    30 Mela Lane
    Rancho Palos Verde
    California 90275
    Usa
    AmericanDirector98853750001
    JONES, Ian Martin Lloyd
    Hewland House Farm
    Rawden Hill Arthington
    LS21 1PS Leeds
    Amministratore
    Hewland House Farm
    Rawden Hill Arthington
    LS21 1PS Leeds
    United KingdomBritishEquity Fund Manager114746480001
    KONTOWTT, Michael Stefan
    2 Farnley Close
    OL12 7SQ Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    2 Farnley Close
    OL12 7SQ Rochdale
    Lancashire
    BritishCompany Director60572810002
    LEE, Nicholas James
    Cox Lane
    KT9 1SJ Chessington
    Bell Microproducts Limited
    Surrey
    Amministratore
    Cox Lane
    KT9 1SJ Chessington
    Bell Microproducts Limited
    Surrey
    EnglandBritishAccountant65430060002
    MACAULAY, Roderick Bruce
    Langland
    Huby
    LS17 0EG Leeds
    North Yorkshire
    Amministratore
    Langland
    Huby
    LS17 0EG Leeds
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant61322370001
    MCCOY, Michael Ryan, Mr.
    c/o Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Amministratore
    c/o Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    United StatesAmericanLegal Counsel187451430001
    MURDAUGH, Russell Raymond
    c/o Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Amministratore
    c/o Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    UsaAmericanVp Finance174072910001
    REIMANN, Beate
    Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Amministratore
    Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    BelgiumGermanCfo183769070002
    SADOWSKI, Raymond John
    Legal Department Avnet Europe Comm. V.A.
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Amministratore
    Legal Department Avnet Europe Comm. V.A.
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    UsaAmericanDirector143504560001
    STEVENS, Mark
    12 Spofforth Hill
    LS22 6SE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Spofforth Hill
    LS22 6SE Wetherby
    West Yorkshire
    BritishPrivate Equity71481160001
    THOMSON, Alasdair John Wardlaw
    39 Leeds Road
    HG2 8AY Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    39 Leeds Road
    HG2 8AY Harrogate
    North Yorkshire
    BritishInvestment Executive93234500001
    TOAL, Jonathan Stephen
    Mill Stream Cottage
    RG19 8AN Headley
    Hampshire
    Amministratore
    Mill Stream Cottage
    RG19 8AN Headley
    Hampshire
    BritishManaging Director109920560001
    TOAL, Jonathan Stephen
    Mill Stream Cottage
    RG19 8AN Headley
    Hampshire
    Amministratore
    Mill Stream Cottage
    RG19 8AN Headley
    Hampshire
    BritishCompany Director109920560001
    WATT, Graeme Alistair
    Legal Department Avnet Europe Comm. V.A.
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Amministratore
    Legal Department Avnet Europe Comm. V.A.
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    EnglandBritishDirector25202730005
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    OPENPSL HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 22 set 2004
    Consegnato il 02 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due on part of each obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the land to the west side of st crispin way haslingden rossendale lancashire by way of fixed charge and has agreed to mortgage to the security trustee its investments its intellectual property its licences and all deeds and documents from time to time relating to the collateral the goodwill and the uncalled capital by way of fixed charge the other receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America, National Association
    Transazioni
    • 02 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 ago 1998
    Consegnato il 18 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due owing or incurred to the chargee (or any of them) by any obligor under the finance documents (or any of them) and under the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag (As Security Trustee for the Secured Parties in Accordance with the Debenture)
    Transazioni
    • 18 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0