TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03591323 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Tony Wilson Place M15 4FN Manchester England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HURST PUBLISHING HOLDINGS LIMITED | 03 lug 1998 | 03 lug 1998 |
| HURST NEWCO 2 LIMITED | 26 giu 1998 | 26 giu 1998 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 29 mar 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 6 pagine | 4.71 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 2 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 035913230008 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 29 mar 2015 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Joanne Walker come amministratore in data 22 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 9 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 035913230008, creata il 15 apr 2015 | 31 pagine | MR01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 035913230007 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 035913230006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Joanne Walker il 18 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Somerset il 17 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Sean Glithero il 17 mar 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Sean Robert Glithero il 17 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4UT a 1 Tony Wilson Place Manchester England M15 4FN in data 23 dic 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 mar 2014 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Tara Collet come amministratore in data 03 ott 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ian Somerset come amministratore in data 25 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 035913230007 | 27 pagine | MR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLITHERO, Sean | Segretario | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | 159905460001 | |||||||
| GLITHERO, Sean Robert | Amministratore | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 129229070002 | |||||
| SOMERSET, Ian | Amministratore | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 191225040001 | |||||
| BESWITHERICK, David Peter | Segretario | 12 Horncastle Close BL8 1XE Bury Lancashire | British | 15959630001 | ||||||
| HODGSON, Simon | Segretario | 28 Malvern Close Woodley RG5 4HL Reading Berkshire | British | 6848030001 | ||||||
| HOWARD, Katherine Frances | Segretario | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | 86019470001 | ||||||
| JENKIN, Elizabeth | Segretario | Sundew Close RG40 5YB Wokingham 7 Berkshire United Kingdom | British | 137518870001 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Segretario | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | 162220750001 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Segretario | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | 162220750001 | ||||||
| MUIRHEAD, Brian Geoffrey | Segretario | Foxley House High Street OX7 5RH Great Rollright Oxfordshire | United Kingdom | 155633620001 | ||||||
| PERRISS, Robyn | Segretario | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | 97879810002 | ||||||
| BYNG-MADDICK, Zillah Ellen | Amministratore | Danehill Lower Earley RG6 4UT Reading Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 147214630001 | |||||
| CASTRO, Nicholas | Amministratore | 18 Branscombe Gardens N21 3BN London | England | British | 39006500001 | |||||
| COLLET, Tara | Amministratore | Wing Close SL7 2RA Marlow 2 Bucks United Kingdom | England | British | 160951420001 | |||||
| HODGSON, Simon | Amministratore | 28 Malvern Close Woodley RG5 4HL Reading Berkshire | British | 6848030001 | ||||||
| HOWARD, Katherine Frances | Amministratore | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | 86019470001 | ||||||
| LANE, Stephen John Roger | Amministratore | 55 Matlock Road Caversham RG4 7BP Reading Berkshire | England | British | 123670600001 | |||||
| LUFF, Graham Ewart | Amministratore | Willows Westbrook Boxford RG20 8DN Newbury Berkshire | British | 46555440002 | ||||||
| MCCALL, Carolyn Julia | Amministratore | New Tesco House Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Hertfordshire | British | 39252480010 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Amministratore | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | United Kingdom | British | 162220750001 | |||||
| MUIRHEAD, Brian Geoffrey | Amministratore | Foxley House High Street OX7 5RH Great Rollright Oxfordshire | England | United Kingdom | 155633620001 | |||||
| PERRISS, Robyn | Amministratore | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | 97879810002 | ||||||
| WALKER, Joanne | Amministratore | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 180119580001 |
TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 15 apr 2015 Consegnato il 20 apr 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 26 feb 2014 Consegnato il 13 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione None. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 26 feb 2014 Consegnato il 13 mar 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Global accession deed | Creato il 03 ott 2003 Consegnato il 10 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge on cash collateral deposit | Creato il 30 apr 2003 Consegnato il 19 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its right title and interest in the deposit moneys from time to time standing to the credit of the cash collateral account held with the royal bank of scotland ac no: 20207614 s/c no: 160400. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental debenture , supplementing and amending a debenture dated 21/07/98 between the company and each of the companies listed therein | Creato il 24 mag 2000 Consegnato il 08 giu 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present ans future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever ) of each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents, the senior subordinated facility agreement and the hedging documents | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge on cash collateral deposit | Creato il 21 lug 1998 Consegnato il 07 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the deed and/or the investor deed dated 4TH july 1998 | |
Brevi particolari First fixed charge all the company's right title and interest in and to the deposit monies and the debt represented by the deposit monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 lug 1998 Consegnato il 07 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and the hedging documents (all as defined in the debenture) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0