TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03591323
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HURST PUBLISHING HOLDINGS LIMITED03 lug 199803 lug 1998
    HURST NEWCO 2 LIMITED26 giu 199826 giu 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 mar 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Soddisfazione dell'onere 035913230008 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 29 mar 2015

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Joanne Walker come amministratore in data 22 giu 2015

    1 pagineTM01

    Memorandum e Statuto

    9 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 mag 2015

    Stato del capitale al 28 mag 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 035913230008, creata il 15 apr 2015

    31 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 035913230007 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 035913230006 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Joanne Walker il 18 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Somerset il 17 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Sean Glithero il 17 mar 2015

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Sean Robert Glithero il 17 mar 2015

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4UT a 1 Tony Wilson Place Manchester England M15 4FN in data 23 dic 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 mar 2014

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Tara Collet come amministratore in data 03 ott 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Somerset come amministratore in data 25 set 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 mag 2014

    Stato del capitale al 28 mag 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 035913230007

    27 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GLITHERO, Sean
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Segretario
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    159905460001
    GLITHERO, Sean Robert
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Amministratore
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish129229070002
    SOMERSET, Ian
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Amministratore
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish191225040001
    BESWITHERICK, David Peter
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    Segretario
    12 Horncastle Close
    BL8 1XE Bury
    Lancashire
    British15959630001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Segretario
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Segretario
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    JENKIN, Elizabeth
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Sundew Close
    RG40 5YB Wokingham
    7
    Berkshire
    United Kingdom
    British137518870001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Segretario
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Segretario
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    British162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Segretario
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    United Kingdom155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Segretario
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South African97879810002
    BYNG-MADDICK, Zillah Ellen
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Danehill
    Lower Earley
    RG6 4UT Reading
    Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish147214630001
    CASTRO, Nicholas
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    Amministratore
    18 Branscombe Gardens
    N21 3BN London
    EnglandBritish39006500001
    COLLET, Tara
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    Amministratore
    Wing Close
    SL7 2RA Marlow
    2
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritish160951420001
    HODGSON, Simon
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    Amministratore
    28 Malvern Close
    Woodley
    RG5 4HL Reading
    Berkshire
    British6848030001
    HOWARD, Katherine Frances
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    25a Gorringe Road
    SP2 7JA Salisbury
    Wiltshire
    British86019470001
    LANE, Stephen John Roger
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    55 Matlock Road
    Caversham
    RG4 7BP Reading
    Berkshire
    EnglandBritish123670600001
    LUFF, Graham Ewart
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Willows Westbrook
    Boxford
    RG20 8DN Newbury
    Berkshire
    British46555440002
    MCCALL, Carolyn Julia
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Tesco House
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Hertfordshire
    British39252480010
    MILLER, Andrew Arthur
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    The Cottage
    Bucklebury Alley, Cold Ash
    RG18 9NN Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritish162220750001
    MUIRHEAD, Brian Geoffrey
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    Amministratore
    Foxley House
    High Street
    OX7 5RH Great Rollright
    Oxfordshire
    EnglandUnited Kingdom155633620001
    PERRISS, Robyn
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Corn Stook
    Skinners Green, Enborne
    RG14 6RE Newbury
    Berkshire
    South African97879810002
    WALKER, Joanne
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    Amministratore
    Tony Wilson Place
    M15 4FN Manchester
    1
    England
    England
    EnglandBritish180119580001

    TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 apr 2015
    Consegnato il 20 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited and Its Successors in Title and Permitted Transferees
    Transazioni
    • 20 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 feb 2014
    Consegnato il 13 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 13 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 feb 2014
    Consegnato il 13 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 13 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Global accession deed
    Creato il 03 ott 2003
    Consegnato il 10 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 10 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on cash collateral deposit
    Creato il 30 apr 2003
    Consegnato il 19 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in the deposit moneys from time to time standing to the credit of the cash collateral account held with the royal bank of scotland ac no: 20207614 s/c no: 160400. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture , supplementing and amending a debenture dated 21/07/98 between the company and each of the companies listed therein
    Creato il 24 mag 2000
    Consegnato il 08 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present ans future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever ) of each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents, the senior subordinated facility agreement and the hedging documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 08 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on cash collateral deposit
    Creato il 21 lug 1998
    Consegnato il 07 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the termsof the deed and/or the investor deed dated 4TH july 1998
    Brevi particolari
    First fixed charge all the company's right title and interest in and to the deposit monies and the debt represented by the deposit monies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank A.G.
    Transazioni
    • 07 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 lug 1998
    Consegnato il 07 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and the hedging documents (all as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London(As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders)
    Transazioni
    • 07 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TRADER MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 mar 2016Inizio della liquidazione
    21 gen 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0