WATKINS HIRE LIMITED

WATKINS HIRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWATKINS HIRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03599314
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WATKINS HIRE LIMITED?

    • Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a. (77390) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova WATKINS HIRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Building
    20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WATKINS HIRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per WATKINS HIRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Birmingham B3 3HN a C/O Teneo Financial Advisory Limited the Colmore Building 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT in data 09 giu 2023

    2 pagineAD01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Toshiba Carrier Uk Ltd Elite House Guildford Road Fetcham Surrey KT22 9UT

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Toshiba Carrier Uk Ltd Elite House Guildford Road Fetcham Surrey KT22 9UT

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Porsham Close Belliver Industrial Estate Plymouth Devon PL6 7DB England a C/O Teneo Financial Advisory Limited 156 Great Charles Street Birmingham B3 3HN in data 08 ago 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 lug 2022

    LRESSP

    Modifica dei dettagli di Carrier Rental Systems (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 21 mag 2018

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 23 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Justin Paddock come amministratore in data 14 ott 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alexandra Elizabeth Gooch come amministratore in data 14 ott 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven Blaby come amministratore in data 14 ott 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Anthony Robinson come amministratore in data 14 ott 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Neil Andrew Vincent Gregor Macgregor come amministratore in data 14 ott 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Simon Ross Harden Mcmullen come amministratore in data 16 ago 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Alexandra Elizabeth Gooch come amministratore in data 16 ago 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Andrew Justin Paddock come amministratore in data 04 gen 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Archibald Ziwanemoyo Hungwe come amministratore in data 04 gen 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2019

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di WATKINS HIRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BONIFACE, Simon
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Techologies House
    England
    Segretario
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Techologies House
    England
    250231460001
    GREGOR MACGREGOR, Neil Andrew Vincent
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    1st Floor, Ash House
    England
    Amministratore
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    1st Floor, Ash House
    England
    United KingdomBritishDirector286329300001
    ROBINSON, John Anthony
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    1st Floor, Ash House
    England
    Amministratore
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    1st Floor, Ash House
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant205997980001
    BLABY, Steven
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Segretario
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    British153931730001
    BOWER, Stephen Andrew
    21 Alverton Drive
    Bishops Cleeve
    GL52 4TD Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    21 Alverton Drive
    Bishops Cleeve
    GL52 4TD Cheltenham
    Gloucestershire
    British46665380002
    SLOSS, Robert
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    Oak House
    England
    Segretario
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    Oak House
    England
    218720440001
    WATKINS, Tonia
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Ward Industrial Estate
    Gloucestershire
    England
    Segretario
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Ward Industrial Estate
    Gloucestershire
    England
    British65091270001
    WAYNE, Harold
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    Segretario nominato
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    British900005490001
    WILCOCK, Laura Jayne
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    Oak House
    England
    Segretario
    Littleton Road
    TW15 1TZ Ashford
    Oak House
    England
    218720470001
    BLABY, Steven James
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Ltd
    England
    Amministratore
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Ltd
    England
    EnglandEnglishAccountant250616320001
    BLABY, Steven James
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Amministratore
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    UkBritishAccountant80801660002
    BOOTH, Allan George
    Church Road
    Ward Industrial Estate
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Limited
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Road
    Ward Industrial Estate
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Limited
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Great BritainBritishBusiness Consultant156989400001
    DREW, Simon John
    Stable Cottage
    HR2 8EG Wormelow
    Herefordshire
    Amministratore
    Stable Cottage
    HR2 8EG Wormelow
    Herefordshire
    EnglandBritishEngineer72486790003
    GOOCH, Alexandra Elizabeth
    Belliver Industrial Estate
    PL6 7DB Plymouth
    Porsham Close
    Devon
    England
    Amministratore
    Belliver Industrial Estate
    PL6 7DB Plymouth
    Porsham Close
    Devon
    England
    EnglandBritishFinance Director286825110001
    HILLS, Mark Edward
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Ward Industrial Estate
    Gloucestershire
    England
    Amministratore
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Ward Industrial Estate
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritishDirector73804920002
    HUNGWE, Archibald Ziwanemoyo
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    England
    Amministratore
    Guildford Road
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    Surrey
    England
    EnglandBritishGeneral Manager240353160001
    JONES, Richard Hilton
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    England
    Amministratore
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    England
    EnglandBritishGeneral Manager101090610001
    LODDMER, Rogel Samuel
    Church Road
    Ward Industrial Estate
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Limited
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Road
    Ward Industrial Estate
    GL15 5EL Lydney
    Watkins Hire Limited
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant156989570001
    MCDONALD, Steven Thomas
    Porsham Close
    Roborough
    PL6 7DB Plymouth
    Toshiba Carrier
    England
    Amministratore
    Porsham Close
    Roborough
    PL6 7DB Plymouth
    Toshiba Carrier
    England
    EnglandBritishFinance Director133653510001
    MCMULLEN, Simon Ross Harden
    Stockley Close
    UB7 9BL West Drayton
    365
    England
    Amministratore
    Stockley Close
    UB7 9BL West Drayton
    365
    England
    EnglandBritishFinancial Director132089160001
    O'KELLY, Paul Brian
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Amministratore
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    United KingdomBritishNone184075280001
    PADDOCK, Andrew Justin
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    England
    Amministratore
    Guildford Road
    Fetcham
    KT22 9UT Leatherhead
    United Technologies House
    England
    EnglandBritishDirector246915550001
    PLATT, Steven Edwin
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Amministratore
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    UkBritishNone184076670001
    STEVENS-SMITH, Terry Victor
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Amministratore
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    UkBritishNone184076550001
    WALTON, Mark Ashley
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Amministratore
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    United KingdomBritishSales Engineer119810660001
    WATKINS, Philip Baden
    Flaxley Abbey
    GL14 1JR Flaxley
    Gloucestershire
    Amministratore
    Flaxley Abbey
    GL14 1JR Flaxley
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector59983980001
    WAYNE, Yvonne
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish900005480001
    WILLIAMS, Roderick Stanley
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    Amministratore
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    United KingdomBritishEngineer43026110001
    WRIGHT, Paul Richard
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Carrier Rental Systems, Unit B
    England
    Amministratore
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Carrier Rental Systems, Unit B
    England
    United KingdomBritishFinance Director130318350001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WATKINS HIRE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    21 mag 2018
    Colima Avenue
    Sunderland Enterprise Park
    SR5 3XE Sunderland
    Unit B
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03807755
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Ward Industrial Estate
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Temperature Control House
    Gloucestershire
    England
    06 apr 2016
    Ward Industrial Estate
    Church Road
    GL15 5EL Lydney
    Temperature Control House
    Gloucestershire
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione08764183
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    WATKINS HIRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 mag 2016
    Consegnato il 05 mag 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 05 mag 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 19 set 2013
    Consegnato il 02 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 01 nov 2012
    Consegnato il 09 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chattels and the documents. 4400-Lb/hr 200PSI trailerised steam boiler s/no.8769/FWT24. *Scrap container* 6000-lb/hr 150 psi containerised steam 5753. 9920--lb/hr 150PSI trailerised steam boiler s/no.8407. For further details of chattels charged please refer to form MG01, the benefit of all contracts and arrangements, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 nov 2012
    Consegnato il 08 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 08 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental chattel mortgage
    Creato il 19 ott 2012
    Consegnato il 24 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the non-vesting assets together with the benefit of all existing guarantees warranties and servicing and maintenance agreements and intellectual property rights licensed to or to which the company is entitled in relation to the assets being scania 480R 6X2 tractor cab reg no BX07 nzn see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • State Securities PLC
    Transazioni
    • 24 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal assignment of contract monies
    Creato il 28 nov 2011
    Consegnato il 29 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any credit balance together with any interests, costs & discounting allowances.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equipment Finance (UK) LTD, Hsbc Asset Finance (UK) LTD Both Together Hsbc
    Transazioni
    • 29 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental chattel mortgage
    Creato il 26 ago 2011
    Consegnato il 01 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title and interest in the non-vesting assets being make: zv counter balance forklift s/n zv 120-06-02066, model: zv 120-06 yom: 2003, make: ford transit vrm: Y4 whl model: t 360 double CAB C/n: WF0CXXGBFC2S38767 and make: olympian s/n: OLY00000LC6A00223 model: gep 500-2 cat generator yom: 2007 (for details of further chattels charged please refer to form MG01) together with all guarantees, warranties, and servicing and maintenance agreements see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • State Securities PLC
    Transazioni
    • 01 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal assignment
    Creato il 08 mar 2011
    Consegnato il 22 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 01 feb 2011
    Consegnato il 03 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder & the company including the associated rights relating thereto, which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 03 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 01 feb 2011
    Consegnato il 03 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 03 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 16 dic 2010
    Consegnato il 21 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Trailerised steam boiler serial no GX4000E4471/2,2020,BT3088,containerised steam boiler 25/9496,7372,434005,steam boiler c/w ici caladaie AX300 serial no 35424.5,0503759,1-234CE00 (for further details of chattels charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 21 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 06 ago 2010
    Consegnato il 12 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Linton services MBR250 used 1149-09-209 2009 boiler house,linton services MBR250 used 1150-09-209 2009 boiler house,linton services MBR250 used 1160-10-209 2009 boiler house,(for further details of chattels charged please refer to form MG01).
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 12 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Long term licence to sub-let
    Creato il 02 giu 2010
    Consegnato il 03 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The full benefit of the sub-letting agreements and the benefit of all guarantees, indemnities, negotiable instruments and securities.
    Persone aventi diritto
    • Ing Lease (UK) LTD
    Transazioni
    • 03 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 apr 2010
    Consegnato il 15 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited & Hsbc Asset Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 15 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 14 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 04 feb 2010
    Consegnato il 11 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The equipment being 30/60 kw air handlings units x 20 serial no AB37189D0103 to 122 inclusive, 4 stainless steel buffer tanks serial no BT001 BT002 BT005 BT006, 22 kw hotboy boilers x 30 serial no V0509-21 to V0509-50 inclusive, for details of chattels charged, please refer to form MG01, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Watkins Engineering Directors Pension Scheme
    Transazioni
    • 11 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 29 gen 2010
    Consegnato il 03 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centric Spv 1 Limited
    Transazioni
    • 03 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 gen 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 27 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Account assignment
    Creato il 18 dic 2009
    Consegnato il 24 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right to all moneys credited to the account number 123659, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Leasing Limited
    Transazioni
    • 24 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 set 2008
    Consegnato il 10 ott 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £19,476 and all other monies due or to become due from the company to the chargee due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The deposit account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Pirrie and James Pirrie
    Transazioni
    • 10 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 02 ago 2007
    Consegnato il 15 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    B10000C containerised hphw boiler N1160/91272,B10002C containerised hphw boiler N1162,B10003C containerised hphw boiler N1163 (for details of further chattels charged please refer to form 395).
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 15 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 02 ago 2007
    Consegnato il 08 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    As per attached schedule of chattels.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 08 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 19 set 2003
    Consegnato il 20 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels plant machinery and things being 14 portable boiler plants s/no's N1166 B10006C 91273, N1195 B10030C 91287, N1168 B10008C 91270, or any part thereof, for details of further chattels charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 20 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 25 mag 2003
    Consegnato il 13 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 17 mar 2003
    Consegnato il 19 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 19 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 16 gen 2003
    Consegnato il 23 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from welco limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Details of charged account: barclays bank PLC re watkins hire limited current account account number 80157465. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Master agreement and charge
    Creato il 07 gen 2003
    Consegnato il 17 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any agreement made whether before on or after the date of the charge between the customer and any person to whom the customer lets or agrees to let the goods on hire.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Assetfinance Limited and (The Finance Company) Acting as Principal or as Agent as Specified Inthe Schedule
    Transazioni
    • 17 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    WATKINS HIRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 lug 2022Inizio della liquidazione
    12 nov 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian Harvey Dean
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Praticante
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Stephen Roland Browne
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    Praticante
    156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0