PROTECTAGROUP LIMITED

PROTECTAGROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROTECTAGROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03599653
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROTECTAGROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova PROTECTAGROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROTECTAGROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MOTAQUOTE HOLDINGS LIMITED11 dic 200211 dic 2002
    FINALROUND LIMITED17 lug 199817 lug 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROTECTAGROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per PROTECTAGROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN a 15 Canada Square London E14 5GL in data 11 mar 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 feb 2019

    LRESSP

    Nomina di Dean Clarke come segretario in data 11 dic 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 11 dic 2018

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    4 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 035996530014 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Geoffrey Costerton Gouriet come segretario in data 03 ago 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 03 ago 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Antonios Erotocritou come amministratore in data 02 mar 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Stephen Mugge come amministratore in data 02 mar 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr David Christopher Ross come amministratore in data 20 dic 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Jacqueline Anne Gregory come segretario in data 20 dic 2016

    2 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    27 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Jennifer Owens come segretario in data 01 mar 2016

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Stephen Mugge il 25 nov 2015

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Scott Egan come amministratore in data 14 set 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PROTECTAGROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CLARKE, Dean
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Segretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    253940010001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomCypriot167795710001
    ROSS, David Christopher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomIrish222326970001
    BROWN, Ian William
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    Segretario
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    British262382040001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    British117669700002
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249430920001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    221973010001
    KIRKNESS, Barrie
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    Segretario
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    British103733180001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    183327890001
    RAGAN, Sharon Marie
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Segretario
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    British67745500003
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    ATTWOOD, Leo Samuel
    127 Kennerleigh Road
    Rumney
    CF3 4BH Cardiff
    Amministratore
    127 Kennerleigh Road
    Rumney
    CF3 4BH Cardiff
    British102933950002
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish125097020001
    BRICE, Richard Ian James
    14 Hensol Villas
    Hensol
    CF72 8JZ Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    14 Hensol Villas
    Hensol
    CF72 8JZ Pontyclun
    Mid Glamorgan
    WalesWelsh120606700001
    BROWN, Ian William
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish262382040001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Amministratore
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritish134140540001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish171398800001
    CHARD, Michael Francis
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    Amministratore
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    UkBritish45725420009
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish149939610001
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish170703910001
    HAGGETT, Linda
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    Amministratore
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    United KingdomWelsh137893590001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritish58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Amministratore
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritish129538180001
    LYONS, Alastair David
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritish193700560001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritish162920630005
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish113694470002
    POWELL, Kenneth John
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    WalesBritish27317930001
    RAGAN, Edwin Robert
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    British61072270005
    RAGAN, Kay Elaine
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    109 Rowan Gardens
    CF38 2TH Llantwit Fardre
    Mid Glamorgan
    British86274390002
    RAGAN, Paul Robert
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    Amministratore
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritish60263070005
    RAGAN, Sharon Marie
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Amministratore
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    British67745500003
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritish147194830001
    REES, Paul
    Plot 1 Springfield Gardens
    Hirwaun
    CF44 9PA Aberdare
    Mid Glamorgan
    Amministratore
    Plot 1 Springfield Gardens
    Hirwaun
    CF44 9PA Aberdare
    Mid Glamorgan
    British72333970002
    RIDEWOOD, Gary Spencer
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    Amministratore
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    WalesBritish112745560001
    RILEY, Dylan James
    14 Three Cliffs Drive
    Southgate
    SA3 2BN Swansea
    Amministratore
    14 Three Cliffs Drive
    Southgate
    SA3 2BN Swansea
    West GlamorganBritish117675190001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PROTECTAGROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Protectagroup Holdings Limited
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Eclipse Park
    Kent
    England
    06 apr 2016
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Eclipse Park
    Kent
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Cardiff
    Numero di registrazione05081105
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PROTECTAGROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 apr 2015
    Consegnato il 22 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    By way of first legal mortgage all legal interest in trademark registration/application number 24770055 as listed in schedule 5 (intellectual property) of the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transazioni
    • 22 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 mag 2013
    Consegnato il 23 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3.1(b)(vii) of the charge, the company charged by way of first fixed charge all its intellectual property, including the following:. Trademark registration/application number 2477005.. pursuant to the charge, the company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed
    Creato il 27 giu 2012
    Consegnato il 07 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 07 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2012
    Consegnato il 06 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 06 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 set 2010
    Consegnato il 18 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 set 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession
    Creato il 04 giu 2008
    Consegnato il 17 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 set 2006
    Consegnato il 04 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 2004
    Consegnato il 14 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 14 commercial street, pontnewydd, cymbran, gwent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 ott 2004
    Consegnato il 21 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 02 apr 2003
    Consegnato il 17 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 38 hannah street porth rhondda cynon taff.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 apr 2003
    Consegnato il 17 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 76 bute street treorchy rhondda cynon taff.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 gen 2003
    Consegnato il 08 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 dic 2002
    Consegnato il 03 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Loan facility agreement
    Creato il 03 ago 2001
    Consegnato il 11 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Up to £150,000 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All debts arising from and the goodwill of the business of after the event litigation insurance carried on by the company all book debts computer software intellectual property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Finsure Premium Finance Limited
    Transazioni
    • 11 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 27 mar 2008
    • 05 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PROTECTAGROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 feb 2019Inizio della liquidazione
    27 giu 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0