UNITE LONDON (ONE) LIMITED

UNITE LONDON (ONE) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUNITE LONDON (ONE) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03600008
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UNITE LONDON (ONE) LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova UNITE LONDON (ONE) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UNITE LONDON (ONE) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PEABODY UNITE (ONE) LIMITED17 set 199817 set 1998
    WANSCO 362 LIMITED17 lug 199817 lug 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di UNITE LONDON (ONE) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per UNITE LONDON (ONE) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per UNITE LONDON (ONE) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Cessazione della carica di Mark Christopher Allan come amministratore in data 20 mag 2016

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come amministratore in data 30 mar 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 17 nov 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 12 ott 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Christopher Robert Szpojnarowicz il 09 set 2015

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ago 2015

    Stato del capitale al 10 ago 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 lug 2014

    Stato del capitale al 17 lug 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ago 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 ago 2013

    SH01

    Nomina di Mr Christopher Robert Szpojnarowicz come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Andrew Reid come segretario

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Christopher Allan il 12 ott 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Michael Bennett come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di UNITE LONDON (ONE) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Segretario
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    British175753180001
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Amministratore
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    United KingdomBritishHead Of Legal And Company Secretary175753180001
    DOE, Howard Francis
    21 Style Close
    Rainham
    ME8 9LS Gillingham
    Kent
    Segretario
    21 Style Close
    Rainham
    ME8 9LS Gillingham
    Kent
    BritishChartered Secretary61730950001
    RANSOME, David Peter
    Silver Birches
    Stinchcombe Hill
    GL11 6AQ Dursley
    Gloucestershire
    Segretario
    Silver Birches
    Stinchcombe Hill
    GL11 6AQ Dursley
    Gloucestershire
    BritishFinance Director67258390002
    REID, Andrew Donald
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    Segretario
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    British67884910002
    W W H COMPANY MANAGEMENT LIMITED
    103 Temple Street
    Bristol
    Segretario nominato
    103 Temple Street
    Bristol
    900006140001
    ALLAN, Mark Christopher
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Amministratore
    The Core
    40 St Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    EnglandBritishFinance Director74371010007
    BENNETT, Michael Peter
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    Amministratore
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    EnglandBritishFinancial Controller86546430001
    BUTLER, Timothy John
    £0a Alma Square
    St Johns Wood
    NW8 9QD London
    Amministratore
    £0a Alma Square
    St Johns Wood
    NW8 9QD London
    BritishChartered Surveyor72276430001
    HARBARD, Paul Joseph
    42 Ebury Bridge Road
    SW1W 8PZ London
    Amministratore
    42 Ebury Bridge Road
    SW1W 8PZ London
    United KingdomBritishFinance Director75580100001
    PORTER, Nicholas Anthony
    Ridge House
    Horse Race Lane Failand
    BS8 3TX Bristol
    Amministratore
    Ridge House
    Horse Race Lane Failand
    BS8 3TX Bristol
    BritishManaging Director45837900004
    RANSOME, David Peter
    Silver Birches
    Stinchcombe Hill
    GL11 6AQ Dursley
    Gloucestershire
    Amministratore
    Silver Birches
    Stinchcombe Hill
    GL11 6AQ Dursley
    Gloucestershire
    EnglandBritishFinance Director67258390002
    RANSOME, David Peter
    Silver Birches
    Stinchcombe Hill
    GL11 6AQ Dursley
    Gloucestershire
    Amministratore
    Silver Birches
    Stinchcombe Hill
    GL11 6AQ Dursley
    Gloucestershire
    EnglandBritishFinance Director67258390002
    ROBINSON, Dickon Hugh Wheelwright
    4 Morgan House
    127 Long Acre
    WC2E 9AA London
    Amministratore
    4 Morgan House
    127 Long Acre
    WC2E 9AA London
    United KingdomBritishDevelopment39339950001
    SHERIDAN, Stephen Lance
    19 Salisbury House
    Bessborough Gardens
    SW1V 2JQ London
    Amministratore
    19 Salisbury House
    Bessborough Gardens
    SW1V 2JQ London
    BritishChartered Accountant71303190001
    WWH COMPANY DIRECTORS LIMITED
    103 Temple Street
    Bristol
    Amministratore delegato nominato
    103 Temple Street
    Bristol
    900006130001

    UNITE LONDON (ONE) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 26 mar 2001
    Consegnato il 26 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,000,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land and buildings at goodwood road, new cross, london, SE14 6BL, title number TGL183367.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust (As Defined)
    Transazioni
    • 26 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 nov 2000
    Consegnato il 15 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee detailed in the legal mortgage dated 6TH november 2000
    Brevi particolari
    Pentland house old road lee green lewisham london SE13 including fixtures and fittings thereon and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 15 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 nov 2000
    Consegnato il 15 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee detailed in the debenture dated 6TH november 2000
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 15 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 lug 2000
    Consegnato il 24 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land and buildings k/a the former naafi stores at master gunners place woolwich london.
    Persone aventi diritto
    • Peabody Unite (One) Limited
    Transazioni
    • 24 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 lug 2000
    Consegnato il 21 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The undertaking, assets, properties, revenues, rights and benefits.
    Persone aventi diritto
    • Peabody Unite (One) Limited
    Transazioni
    • 21 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 feb 2000
    Consegnato il 17 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 17 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 feb 2000
    Consegnato il 12 feb 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    22, 24 & 26 woodgrange road london EC7.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 12 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 dic 1999
    Consegnato il 12 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    331 romford road forest gate london borough of newham.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 12 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 dic 1999
    Consegnato il 12 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 12 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 dic 1999
    Consegnato il 05 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 05 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 15 dic 1999
    Consegnato il 05 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Sunlight apartments sunlight square london E2.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 05 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 lug 1999
    Consegnato il 24 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 24 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 lug 1999
    Consegnato il 24 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    John bell house king david lane shadwell london E1 including all fixtures and fittings thereon interst therein and the proceeds of sale thereof by way of assignment and the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 24 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 lug 1999
    Consegnato il 24 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land at nicholas road london E1 including fixtures and fittings thereon and the proceeds of sale together with the full benefit of all licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 24 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 lug 1999
    Consegnato il 24 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a nicholas road london E1. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 24 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 giu 1999
    Consegnato il 29 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a telephone house 4-20 (even) woodgrange road forest gate london E7 f/h title EX50058 and EGL352886. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 29 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 giu 1999
    Consegnato il 23 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Telephone house 4-20 (even) woodgrange road forest gate london E7 (including fixtures and fittings thereon) the proceeds of sale..and all monies received as compensation or under any policy of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 23 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 mar 1999
    Consegnato il 16 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a poland house 293-305 high street stratford london t/n EGL337215 and the proceeds of sale thereof and the benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 16 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mar 1999
    Consegnato il 16 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governors of the Peabody Trust
    Transazioni
    • 16 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 mar 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0