SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED

SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSIMON GROUP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03600576
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    130 Shaftesbury Avenue
    W1D 5AR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRECIS (1663) LIMITED20 lug 199820 lug 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da * Clough Lane North Killingholme North Lincolnshire DN40 3LX* in data 22 ott 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 20 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ago 2013

    Stato del capitale al 14 ago 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joost Marc Edmond Rubens il 01 ago 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr. Michel René L Jadot come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Franciscus Johannes Antonius Las come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gary Walker come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Freddy Bracke come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    legacy

    7 pagineMG01

    legacy

    11 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 20 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Patricia Grout come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Patricia Ann Grout il 10 gen 2011

    3 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 20 lug 2010

    13 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JADOT, Michel René L
    Shaftesbury Avenue
    W1D 5AR London
    130
    Amministratore
    Shaftesbury Avenue
    W1D 5AR London
    130
    LuxembourgBelgianCompany Director178739520001
    LAS, Franciscus Johannes Antonius
    Shaftesbury Avenue
    W1D 5AR London
    130
    Amministratore
    Shaftesbury Avenue
    W1D 5AR London
    130
    NetherlandsDutchCompany Director178713940001
    RUBENS, Joost Marc Edmond
    Shaftesbury Avenue
    W1D 5AR London
    130
    Amministratore
    Shaftesbury Avenue
    W1D 5AR London
    130
    BelgiumBelgianDirector134435140002
    CATT, Richard John
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    Segretario
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    British1367810004
    GROUT, Patricia Ann
    Clough Lane
    North Killingholme
    DN40 3LX North Lincolnshire
    Segretario
    Clough Lane
    North Killingholme
    DN40 3LX North Lincolnshire
    British126598200002
    HOLLOWAY, Mark Adrian
    79 Cassiobury Drive
    WD1 3AG Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    79 Cassiobury Drive
    WD1 3AG Watford
    Hertfordshire
    British60953190001
    KEANE, Adrian Spencer
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    Segretario
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    BritishCompany Director62552110002
    NOLAN, Niall Joseph
    14 Savona Close
    Wimbledon
    SW19 4HT London
    Segretario
    14 Savona Close
    Wimbledon
    SW19 4HT London
    IrishCompany Director114924350001
    VAN BELLINGEN, Frank Luc Renaat
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    Segretario
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    BelgianDirector105595770001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Segretario
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRACKE, Freddy Achiel
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Amministratore
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    LuxembourgBelgianCompany Director147405030001
    BRACKE, Freddy Achiel
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Amministratore
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    LuxembourgBelgianCompany Director147405030001
    CATT, Richard John
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    Amministratore
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    EnglandBritishLawyer1367810004
    CHADWICK, Timothy John Mackenzie
    8 Clifton House
    Hollywood Road
    SW10 9XA London
    Amministratore
    8 Clifton House
    Hollywood Road
    SW10 9XA London
    United KingdomBritishInvestment Banker119078580001
    CIGRANG, Christian Leon
    Arthur Goemaerelei 24
    Antwerpen
    2018
    Belgium
    Amministratore
    Arthur Goemaerelei 24
    Antwerpen
    2018
    Belgium
    BelgiumBelgianCompany Director74484810001
    DUNNING, Pamela Elizabeth
    2 The Clockhouse
    Glebe Court
    CM23 5AD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 The Clockhouse
    Glebe Court
    CM23 5AD Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishSolicitor57501620001
    FREEMAN, Edwin
    White Cottage Rasen Road
    Tealby
    LN8 3XH Market Rasen
    Lincolnshire
    Amministratore
    White Cottage Rasen Road
    Tealby
    LN8 3XH Market Rasen
    Lincolnshire
    BritishCompany Director9094510002
    KEANE, Adrian Spencer
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    Amministratore
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    United KingdomBritishCompany Director62552110002
    PENFOLD, Diane June
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    Amministratore
    43 Eagle Court
    Hermon Hill
    E11 1PD London
    United KingdomBritishCompany Secretary59962430002
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Amministratore
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director22018030002
    VAN BELLINGEN, Frank Luc Renaat
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    Amministratore
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    BelgiumBelgianDirector105595770001
    WALKER, Gary John
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Amministratore
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    EnglandBritishCompany Director134900940001
    WILLIAMSON, Mark David
    The Old Coach House
    Wierton Hill
    ME17 4JS Boughton Monchelsea
    Kent
    Amministratore
    The Old Coach House
    Wierton Hill
    ME17 4JS Boughton Monchelsea
    Kent
    BritishChartered Accountant50785820002
    WILSON, Clare Alice
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    Amministratore
    75 Ifield Road
    SW10 9AU London
    BritishSolicitor47611200001
    EXREALM LIMITED
    The Quadrangle 2nd Floor
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    Amministratore
    The Quadrangle 2nd Floor
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    65100670001
    MARITIME ADVISORY SERVICES LTD
    The Quadrangle
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    Amministratore
    The Quadrangle
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    126598130001

    SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 01 set 2011
    Consegnato il 06 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank
    Transazioni
    • 06 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A charge over shares
    Creato il 01 set 2011
    Consegnato il 06 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the charged securities together with all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank
    Transazioni
    • 06 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A charge over shares
    Creato il 28 set 2007
    Consegnato il 09 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged securities together with all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis International Finance (Dublin)
    Transazioni
    • 09 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 mar 2004
    Consegnato il 19 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the principal borrower and each chargor and/or any other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC: Capital Markets (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission
    Creato il 18 mar 1999
    Consegnato il 06 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities whether present and future due or to become due from the company or any other company (as defined) or any relevant borrower (as defined) to the chargee and to the beneficiaries on any account whatsoever (except any monies or liabilities due owing or incurred by any other company as guarantor (as defined)) relating to a composite guarantee and debenture dated 7TH april 1997 as supplemented by a deed of admission dayed 11TH august 1998
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC(As Agent and Trustee for the Beneficiaries,as Defined)
    Transazioni
    • 06 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 lug 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 18 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission
    Creato il 18 mar 1999
    Consegnato il 06 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee relating to a composite guarantee and debenture dated 7TH april 1997 as supplemented by a deed of admission dated 11TH august 1998
    Brevi particolari
    Floating charge all the charging company's undertaking property assets and revenues present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Simon Group PLC
    Transazioni
    • 06 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 dic 1998
    Consegnato il 16 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SIMON GROUP HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 ago 2014Data di scioglimento
    01 ott 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Martin N Widdowson
    130 Shaftesbury Avenue
    W1D 5AR London
    Praticante
    130 Shaftesbury Avenue
    W1D 5AR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0