FOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED

FOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03601515
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE BUTLER'S PANTRY (SOUTHERN) LIMITED21 lug 199821 lug 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 lug 2015

    Stato del capitale al 24 lug 2015

    • Capitale: GBP 62,500
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 lug 2014

    Stato del capitale al 22 lug 2014

    • Capitale: GBP 62,500
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    14 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 set 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 10 set 2013

    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough SL3 0QX England* in data 10 set 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 mar 2013

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Thomas come amministratore

    2 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Steve Wood come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 21 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Gavin Cox il 01 nov 2011

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Steve Wood il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Thomas il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Gavin Cox il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough England SL3 0EN* in data 13 nov 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 01 ott 2011

    6 pagineAA

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02

    Cessazione della carica di Paul Kingsley Bates come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Julian Momen come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Gavin Cox come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Julian Momen come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di FOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Segretario
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165757090001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritish153840250001
    JENKINS, Christopher Michael
    Penny Pines
    Fyfield
    SP11 8EL Andover
    Hampshire
    Segretario
    Penny Pines
    Fyfield
    SP11 8EL Andover
    Hampshire
    British1916700001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Segretario
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150497650001
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Segretario
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    British48323870001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Segretario
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British71735980002
    WILKINSON, David
    39 Wisley Gardens
    GU14 0RS Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    39 Wisley Gardens
    GU14 0RS Farnborough
    Hampshire
    British61995880001
    CRS LEGAL SERVICES LIMITED
    Newfoundland Chambers
    43a Whitchurch Road
    CF4 3JN Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Newfoundland Chambers
    43a Whitchurch Road
    CF4 3JN Cardiff
    South Glamorgan
    900004280001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    Segretario
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    116685100001
    CHREE, Ian Charles Gordon
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    Amministratore
    6 The Grange
    Perceton
    KA11 2EU Irvine
    Ayrshire
    ScotlandBritish65127980003
    HAZELDEAN, James William
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish10359650007
    HULBERT, David John
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    St Michaels Way
    Steeple Claydon
    MK18 2QD Buckingham
    53
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish136463020001
    KILSHAW, David Charles
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    Amministratore
    Drumallan
    283 North Deeside Road, Cults
    AB15 9PA Aberdeen
    United KingdomBritish18455470002
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish157009150001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritish51784930002
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Amministratore
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    British96978470001
    ROBERTSHAW, Paul
    1 Bennetts Rise
    Church Lane East
    GU11 3ST Aldershot
    Hampshire
    Amministratore
    1 Bennetts Rise
    Church Lane East
    GU11 3ST Aldershot
    Hampshire
    British61995850002
    ROBERTSON, Neil Charles
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    Amministratore
    16 Barmstedt Drive
    LE15 6RG Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish48323870001
    ROBINSON, Stuart John
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    Amministratore
    Westfield House
    Harburn
    EH55 8RB West Calder
    West Lothian
    British63448390001
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Amministratore
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    EnglandBritish63844650001
    THORNE, Michael
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    48 Station Road
    Woburn Sands
    MK17 8RU Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British71735980002
    THORPE, Alan James
    29 Walace Wynd
    Cambuslang
    G72 8SE Glasgow
    Amministratore
    29 Walace Wynd
    Cambuslang
    G72 8SE Glasgow
    United KingdomBritish345385730001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British37845970003
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Amministratore
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritish232132390001
    MC FORMATIONS LIMITED
    Newfoundland Chambers
    43a Whitchurch Road
    CF4 3JN Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore delegato nominato
    Newfoundland Chambers
    43a Whitchurch Road
    CF4 3JN Cardiff
    South Glamorgan
    900004800001

    FOOD PARTNERS ALDERSHOT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite corporate guarantee
    Creato il 31 ott 2001
    Consegnato il 17 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    To exercise a right of set-off or retention in respect of all money at any time standing to the credit of the guarantor's accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ott 2001
    Consegnato il 14 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 25 set 2001
    Consegnato il 02 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0