BRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED

BRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03611868
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova BRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BOUNDRESULT LIMITED07 ago 199807 ago 1998

    Quali sono gli ultimi bilanci di BRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per BRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 ago 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 ago 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 set 2015

    Stato del capitale al 25 set 2015

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2014

    Stato del capitale al 05 nov 2014

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Cessazione della carica di Timothy Nicholas Siviter come amministratore in data 04 nov 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 ott 2013

    Stato del capitale al 16 ott 2013

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 07 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Nomina di Mr Timothy Nicholas Siviter come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Jonathan David Robin Westwood come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Faulkner come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert Faulkner come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2011

    4 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 07 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2010

    1 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di BRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WESTWOOD, Jonathan David Robin
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector165439430001
    FAULKNER, Robert Michael Stanley
    12 Newfield Crescent
    B63 3SS Halesowen
    West Midlands
    Segretario
    12 Newfield Crescent
    B63 3SS Halesowen
    West Midlands
    BritishProject Manager27616940001
    LAWRENCE, Angela Rosemary
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    Segretario
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    BritishPrivate Secretary27616950001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BIRCH, Sally Ann
    150 Wilden Lane
    DY13 9LP Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    150 Wilden Lane
    DY13 9LP Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritishSecretary123289480001
    FAULKNER, Robert Michael Stanley
    12 Newfield Crescent
    B63 3SS Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    12 Newfield Crescent
    B63 3SS Halesowen
    West Midlands
    EnglandBritishSurveyor27616940001
    LAWRENCE, Angela Rosemary
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    Broadway 7 Chapel Court
    DY10 2UQ Kidderminster
    Worcestershire
    BritishPrivate Secretary27616950001
    SIVITER, Timothy Nicholas
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector165439550001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Jonathan David Robin Westwood
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    06 ago 2016
    The Old Library
    Vale Road
    DY13 8YJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    BRIDGE STREET DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of rental assignment
    Creato il 03 nov 2009
    Consegnato il 14 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    With full guarantee the rents see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 14 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 21 ott 2005
    Consegnato il 03 nov 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 66 and 67 broad street worcester t/no HW165318. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 03 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 mag 2005
    Consegnato il 25 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mag 2002
    Consegnato il 03 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 66/67 bridge street/2 bank street worcester t/n HW165318. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 10 gen 2000
    Consegnato il 13 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 66/67 broad street and 3 bank street worcester t/n HW165318. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transazioni
    • 13 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0